MAGIC NURSERIES `A` LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAGIC NURSERIES `A` LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05137661
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    • Vorschule (85100) / Erziehung

    Wo befindet sich MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Tuscany House
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Hampshire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Mai 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 051376610020 vollständig

    1 SeitenMR04

    Änderung der Details des Direktors für Ms Lydia Joy Hopper am 08. März 2022

    2 SeitenCH01

    Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte

    2 SeitenSH10

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    26 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Mai 2021 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom zum Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Sekretärs für Prism Cosec Limited am 26. Mai 2021

    1 SeitenCH04

    Kapitalaufstellung am 20. Apr. 2021

    • Kapital: GBP 0.01
    5 SeitenSH19

    Beschlüsse

    Resolutions
    6 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    8 SeitenMA

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    8 SeitenMA

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    6 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    26 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Adrian Richard Moore als Geschäftsführer am 17. Juli 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Lydia Joy Hopper als Direktor am 17. Juli 2020

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Richard Moore am 17. Juni 2020

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin James Lawson am 15. Mai 2020

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin James Lawson am 15. Mai 2020

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PRISM COSEC LIMITED
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Sekretär
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer05533248
    116519070002
    HOPPER, Lydia Joy
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish273239570002
    LAWSON, Colin James
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish238908190001
    REED, Jean Patricia, Dr
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    Sekretär
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    British84319810001
    REED, Thomas Christian
    13 Esmond Road
    W4 1JG London
    Sekretär
    13 Esmond Road
    W4 1JG London
    British82247050002
    WRIGHT, Zoe Louise
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    205435200001
    ALI, Syed Haider
    c/o Magic Nurseries 'A' Ltd
    Fishers Lane
    W4 1RX London
    Swan Centre
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Magic Nurseries 'A' Ltd
    Fishers Lane
    W4 1RX London
    Swan Centre
    United Kingdom
    SingaporePakistani97946730002
    GRIFFITH, Ellis Keith
    105 Queenswood Gardens
    Wanstead
    E11 3SF London
    Geschäftsführer
    105 Queenswood Gardens
    Wanstead
    E11 3SF London
    EnglandBritish90661250001
    MOORE, Adrian Richard
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish96121170002
    REED, Thomas Christian
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Esmond Road
    W4 1JG London
    13
    United Kingdom
    JerseyBritish132988450003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MAGIC NURSERIES `A` LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Grandir Uk Limited
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    03. Jan. 2017
    White Hart Lane
    RG21 4AF Basingstoke
    Tuscany House
    Hampshire
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales Companies Registry
    Registrierungsnummer10519700
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MAGIC NURSERIES `A` LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 22. Dez. 2017
    Geliefert am 02. Jan. 2018
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 07. Apr. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Jan. 2015
    Geliefert am 02. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Property k/a 471 wellingborough road northampton titel no NN50700.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Aug. 2014
    Geliefert am 15. Aug. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Freehold property known as the laurels 1514 melton road queniborough leicester t/n LT83619.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 31. Juli 2014
    Geliefert am 01. Aug. 2014
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2012
    Geliefert am 06. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H grove mill, 117 grove road, hitchin, hertfordshire, being the whole of the property registered with f/h title number HD391748.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2012
    Geliefert am 06. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H ravenstone house, the common, redbourn, st albans, being the whole of the property registered with f/h title number HD264527.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2012
    Geliefert am 06. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 473 wellingborough road, northampton, northamptonshire, being the whole of the property registered with f/h title number NN81860.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2012
    Geliefert am 06. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 45 barwell road, kirby muxloe, being the whole of the property registered with f/h title number LT304446.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2012
    Geliefert am 06. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 120 charnwood road, shepshed, leicester, being the whole of the property registered with f/h title number LT78015.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2012
    Geliefert am 06. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the west side of market place and north west side of silver street being the whole of the property registered with f/h title number LT265408.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 24. Sept. 2012
    Geliefert am 28. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and limited liability partnerships named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 19. Sept. 2008
    Geliefert am 25. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2007
    Geliefert am 21. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Grove mill 117 grove road hitchin herts. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 03. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Ravenstone house northcote south common hemel hempstead road redbourn herts. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 03. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ravenstone house 473 wellingborough road northampton. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 25. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 45 barwell road, kirby, muxloe, t/no LT304446. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 25. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land and buildings on the west side of market place and north west side of silver street, t/no LT265408. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 25. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 120 charnwood road, shepshed, LT78015. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 25. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the south side of pinfoldgate, loughborough, t/no LT242762. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 25. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0