BRAND NEW CO (225) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRAND NEW CO (225) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05137991 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRAND NEW CO (225) LIMITED?
- Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen
Wo befindet sich BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 7 St. Petersgate SK1 1EB Stockport Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BARDSLEY LIMITED | 12. Aug. 2005 | 12. Aug. 2005 |
| BRAND NEW CO (225) LIMITED | 26. Mai 2004 | 26. Mai 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 16 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2020 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2019 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2018 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Globe Square Dukinfield Cheshire SK16 4RG zum 7 st. Petersgate Stockport Cheshire SK1 1EB am 11. Mai 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2014 bis 30. Juni 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graeme Spencer als Geschäftsführer am 30. Juni 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Graeme Spencer am 26. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Roland Bardsley am 26. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Edmund Paul Bodnar-Horvath als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Macdougal als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRAND NEW CO (225) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDSLEY, Roland | Geschäftsführer | St. Petersgate SK1 1EB Stockport 7 Cheshire | United Kingdom | British | 140518810002 | |||||
| BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul | Geschäftsführer | St. Petersgate SK1 1EB Stockport 7 Cheshire | England | British | 46232460002 | |||||
| RAFTERY, Paul Matthew | Sekretär | 9 Redcourt Avenue M20 3QL Manchester | British | 62586740002 | ||||||
| STUBLEY, Caroline | Sekretär | 4 Limewood Meadow Church Road M29 7UZ Astley | British | 163442060001 | ||||||
| MACDOUGAL, Neil Charles | Geschäftsführer | The Garden House Off Chester Road, Tabley WA16 OHA Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 93401120003 | |||||
| MCCARREN, Lee Scott | Geschäftsführer | Chadwicks Close Farm Off Coal Pit Road Smithills BL1 7PB Bolton Lancashire | England | British | 107908930001 | |||||
| PURKIS, Stephen Robert | Geschäftsführer | Globe Square Dukinfield SK16 4RG Cheshire | England | British | 135467600002 | |||||
| SPENCER, Graeme | Geschäftsführer | Globe Square Dukinfield SK16 4RG Cheshire | England | British | 140712180002 | |||||
| STUBLEY, Caroline | Geschäftsführer | 4 Limewood Meadow Church Road M29 7UZ Astley | United Kingdom | British | 163442060001 | |||||
| THOMPSON, Alan Christopher | Geschäftsführer | 21a Spath Road Didsbury M20 2QT Manchester Greater Manchester | United Kingdom | British | 39558890001 |
Hat BRAND NEW CO (225) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 05. Mai 2011 Geliefert am 11. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Blocked account charge | Erstellt am 08. Apr. 2010 Geliefert am 15. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit being all or any of the amounts of the blocked account charge numbered 39139336 with sort code 01-05-31 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Nov. 2007 Geliefert am 28. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the south side of worsley road worsley manchester (t/no GM138828) and all that land shown edged red on plan 2 annexed to the deed and all that land shown edged red on plan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 19. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h land on the east side of mottram old road stalybridge t/n GM118130,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Okt. 2005 Geliefert am 27. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM952048 and all that f/h land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM945234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Nov. 2004 Geliefert am 15. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BRAND NEW CO (225) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0