BRAND NEW CO (225) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRAND NEW CO (225) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05137991
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    • Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen

    Wo befindet sich BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7 St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BARDSLEY LIMITED12. Aug. 200512. Aug. 2005
    BRAND NEW CO (225) LIMITED26. Mai 200426. Mai 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    16 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2020

    14 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2019

    16 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Apr. 2018

    17 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Globe Square Dukinfield Cheshire SK16 4RG zum 7 st. Petersgate Stockport Cheshire SK1 1EB am 11. Mai 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Apr. 2017

    LRESEX

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name09. Sept. 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 20. Juli 2016

    RES15

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 20. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015

    15 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2014 bis 30. Juni 2015

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 16. Juni 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    15 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Graeme Spencer als Geschäftsführer am 30. Juni 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 13. Juni 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Graeme Spencer am 26. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Roland Bardsley am 26. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Robert Edmund Paul Bodnar-Horvath als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Neil Macdougal als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRAND NEW CO (225) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARDSLEY, Roland
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Geschäftsführer
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    United KingdomBritish140518810002
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    Geschäftsführer
    St. Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    7
    Cheshire
    EnglandBritish46232460002
    RAFTERY, Paul Matthew
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    Sekretär
    9 Redcourt Avenue
    M20 3QL Manchester
    British62586740002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Sekretär
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    British163442060001
    MACDOUGAL, Neil Charles
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish93401120003
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish107908930001
    PURKIS, Stephen Robert
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Geschäftsführer
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish135467600002
    SPENCER, Graeme
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    Geschäftsführer
    Globe Square
    Dukinfield
    SK16 4RG Cheshire
    EnglandBritish140712180002
    STUBLEY, Caroline
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    Geschäftsführer
    4 Limewood Meadow
    Church Road
    M29 7UZ Astley
    United KingdomBritish163442060001
    THOMPSON, Alan Christopher
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    21a Spath Road
    Didsbury
    M20 2QT Manchester
    Greater Manchester
    United KingdomBritish39558890001

    Hat BRAND NEW CO (225) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 05. Mai 2011
    Geliefert am 11. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 11. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Blocked account charge
    Erstellt am 08. Apr. 2010
    Geliefert am 15. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit being all or any of the amounts of the blocked account charge numbered 39139336 with sort code 01-05-31 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Nov. 2007
    Geliefert am 28. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the south side of worsley road worsley manchester (t/no GM138828) and all that land shown edged red on plan 2 annexed to the deed and all that land shown edged red on plan. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 19. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land on the east side of mottram old road stalybridge t/n GM118130,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 2005
    Geliefert am 27. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM952048 and all that f/h land being part of whitefield golf club, higher lane, whitefield t/no GM945234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 10. Nov. 2004
    Geliefert am 15. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat BRAND NEW CO (225) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Okt. 2021Soll aufgelöst werden am
    26. Apr. 2017Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Vincent Andrew Simmons
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire
    Praktiker
    7 St Petersgate
    SK1 1EB Stockport
    Cheshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0