MAYFAIR GAMING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MAYFAIR GAMING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05140722 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MAYFAIR GAMING LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MAYFAIR GAMING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Seebeck House 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Buckinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MAYFAIR GAMING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DABBER LIMITED | 15. Juni 2004 | 15. Juni 2004 |
| PINCO 2138 LIMITED | 28. Mai 2004 | 28. Mai 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAYFAIR GAMING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MAYFAIR GAMING LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MAYFAIR GAMING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Hamilton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew James Hall als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 17a Market Place Loughborough Leicestershire LE11 3EA* am 06. März 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Kevin Hamilton am 01. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Byron Evans als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Proctor als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Proctor als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O C/O Emw Picton Howell Llp Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Mattingley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung von Emw Secretaries Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MAYFAIR GAMING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire England |
| 93910510003 | ||||||||||
| EVANS, Byron | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | English | 140884750001 | |||||||||
| HALL, Andrew James | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 30306840002 | |||||||||
| HARDING, Nicholas Simon | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 150860820001 | |||||||||
| MATTINGLEY, Brian | Sekretär | Market Place LE11 3EA Loughborough 17a Leicestershire | 150195100001 | |||||||||||
| MURRAY, Stephanie | Sekretär | Market Place LE11 3EA Loughborough 17a Leicestershire | Australian | 123290920002 | ||||||||||
| PROCTOR, Matthew Frederick | Sekretär | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire England | 151171890001 | |||||||||||
| VINER, Paul | Sekretär | 20 Denman Drive North NW11 6RB London | British | 117768960001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||||||
| DIXON, Gillian | Geschäftsführer | Croft House High Hesket CA4 0HS Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | 146371490001 | |||||||||
| FARRER-BROWN, Mark David | Geschäftsführer | Flat 15 22 Brook Mews North W2 3BW London | England | British | 142028830001 | |||||||||
| HAMILTON, Kevin | Geschäftsführer | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147485660001 | |||||||||
| HANNAH, Simon | Geschäftsführer | 35 Turgis Road GU51 1EL Fleet Hampshire | United Kingdom | British | 98633850001 | |||||||||
| JEPP, Mark | Geschäftsführer | 67 Humber Street DE65 5NW Hilton Derbyshire | England | British | 184171270001 | |||||||||
| JOHNSON, Luke | Geschäftsführer | 32 Clarendon Gardens W9 1AZ London | England | British | 141745230001 | |||||||||
| MATTINGLEY, Brian Roger | Geschäftsführer | Market Place LE11 3EA Loughborough 17a Leicestershire | United Kingdom | British | 22417130002 | |||||||||
| MAY, Paul Edward | Geschäftsführer | The Old Rectory Bradden NN12 8ED Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 83046570001 | |||||||||
| MURRAY, Stephanie | Geschäftsführer | Market Place LE11 3EA Loughborough 17a Leicestershire | England | Australian | 123290920002 | |||||||||
| PROCTOR, Matthew Frederick | Geschäftsführer | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire England | England | British | 136671560001 | |||||||||
| VINER, Paul | Geschäftsführer | 20 Denman Drive North NW11 6RB London | British | 117768960001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
Hat MAYFAIR GAMING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 20. Apr. 2010 Geliefert am 27. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, each borrower, each obligor and each chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Aug. 2006 Geliefert am 18. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging companies or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H heaton bingo and social club, heaton assembly buildings, heaton road, newcastle-upon-tyne t/nos ty 400329 and nd 2002; l/h pasdena bingo club, lowtown, pudsey, leeds t/no WYK790515; l/h riva bingo club, 2ND floor, castlegate leisure centre, lombard street, newark, nottinghamshire t/no nt 409117 (for details of further property charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juni 2005 Geliefert am 24. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholders and the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policy | Erstellt am 09. Sept. 2004 Geliefert am 14. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy being, policy number: ah/300002/04/01 taken out by the company with universal accident & health over the life of mr simon hannah. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0