CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05150138 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?
- (8514) /
Wo befindet sich CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Craegmoor House Perdiswell Park WR3 7NW Worcester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Manson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David James Hall als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Henry Scott als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jason David Lock als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Franzidis als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Morrison als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christine Cameron als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Albert Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Ball als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Spurling als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL, David James | Sekretär | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | 159633840001 | |||||||
| EVANS, Avril Emma Margaret | Geschäftsführer | Woodlands Quarhouse Brimscombe GL5 2RR Stroud Gloucestershire | England | British | 111954610001 | |||||
| FRANZIDIS, Matthew | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | Uk | 129251300001 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | British | 144822040001 | |||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | British | 174231320001 | |||||
| MORRISON, Scott | Sekretär | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
| BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Sekretär | 7th Floor Beaufort House 15 St Botolph Street EC3A 7NJ London | 39680630001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANDREWS, Carole | Geschäftsführer | 155 Watermoor Road GL7 1LF Cirencester Gloucestershire | British | 102238960001 | ||||||
| BAILEY, Anne | Geschäftsführer | 25 Church Lane SK7 1RQ Woodford Cheshire | United Kingdom | British | 118289800001 | |||||
| BALL, Julian Charles | Geschäftsführer | Mill Fleam Hilton DE65 5HE Derby 14 Derbyshire | England | British | 138044110001 | |||||
| BYRNE, Michael | Geschäftsführer | 71a-71c High Street TN21 8HU Heathfield East Sussex | Canadian | 100296200001 | ||||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Geschäftsführer | Orchard Manor Church Lane Martin Hussingtree WR3 8TQ Worcester Worcestershire | England | British | 113187140001 | |||||
| CAMERON, Christine Isabel | Geschäftsführer | 10 Mount Crescent HR1 NQ1 Hereford | England | British | 163745150001 | |||||
| CAVANAGH, Peter Kenneth | Geschäftsführer | 8 Fir Grove Paddington WA1 3JF Warrington | British | 114627410002 | ||||||
| FOTHERGILL, David | Geschäftsführer | Woodfordes Stoke St Mary TA3 5BY Taunton Somerset | British | 35902810001 | ||||||
| HAYES, Paul Stuart | Geschäftsführer | The Long Barn Shoulton Hallow WR2 6PX Worcester Worcestershire | England | British | 92558190002 | |||||
| HILL, Margaret | Geschäftsführer | 11 Pear Tree Close Hollingsworth S43 2LU Chesterfield Derbyshire | England | British | 102587360001 | |||||
| KEATING, Denise Elizabeth | Geschäftsführer | 62 Church Street Cogenhoe NN7 1LS Northampton Northamptonshire | England | British | 111513540001 | |||||
| MANSON, David Lindsay | Geschäftsführer | 111 Lodge Road Knowle B93 0HG Solihull West Midlands | England | British | 126071210001 | |||||
| MURRAY, Andrew John | Geschäftsführer | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | 110957990001 | ||||||
| NEWELL, John | Geschäftsführer | 2 Spratts Bridge Chew Magna BS40 8RZ Bristol | British | 87428820001 | ||||||
| POINTER, David Richard | Geschäftsführer | Cuckoo Cottage Cuckoo Cage Lane Tatenhill DE13 9RX Burton On Trent Staffordshire | England | British | 283804350001 | |||||
| PRESTON, Mary | Geschäftsführer | 1 Pall Mall Cottage Rivington Lane BL6 7RY Bolton | United Kingdom | British | 124068010001 | |||||
| SAVILLE, Richard Cyril Campbell | Geschäftsführer | Fairings Valley Way SL9 7PL Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 38530070001 | |||||
| SMIT, Wynne Carol | Geschäftsführer | 506 Oundle Road Orton Longueville PE2 7DJ Peterborough Cambridgeshire | England | British | 114625570001 | |||||
| SMITH, Albert Edward | Geschäftsführer | Flint House Froxfield SN8 3JY Marlborough Wiltshire | England | British | 77631340001 | |||||
| SPURLING, Julian Neville Guy | Geschäftsführer | Foundry House GU35 9LY Kingsley Hampshire | England | British | 110225070001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY NO.2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and | Erstellt am 02. Okt. 2008 Geliefert am 08. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 11. März 2006 Geliefert am 21. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Overdraft debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Overdraft debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Overdraft debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the book and record,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Overdraft debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Overdraft debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the book and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Overdraft debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash.the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Overdraft debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts, the books and records, the cash, the stocks, the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Warehouse debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Warehouse debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Warehouse debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Warehouse debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Warehouse debenture | Erstellt am 16. Okt. 2003 Erworben am 31. Dez. 2004 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000,000 | |
Kurze Angaben The benefit of the business contracts,the books and records,the cash,the stocks,the book debts of the chargor. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0