SPEEDFIT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SPEEDFIT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05156671 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPEEDFIT LIMITED?
- Elektroinstallation (43210) / Bauwesen
- Installation von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen (43220) / Bauwesen
Wo befindet sich SPEEDFIT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Essex England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPEEDFIT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPEEDFIT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 051566710010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Sept. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Sure Maintenance Group Limited as a person with significant control on 13. Apr. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Patrick Joseph Coleman als Direktor am 10. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter David Mawby Smith als Direktor am 01. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Mcmahon als Geschäftsführer am 30. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Stephen Cornes als Geschäftsführer am 30. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR United Kingdom zum Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane Basildon Essex SS14 3BZ am 09. Apr. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 051566710009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 051566710010, erstellt am 19. Dez. 2018 | 69 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr John William Charles Charlton als Direktor am 12. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy John Cobbett Simpson als Geschäftsführer am 15. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 King George Close Romford Essex RM7 7LS United Kingdom zum St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR am 11. Mai 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPEEDFIT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLTON, John William Charles | Sekretär | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | 230717980001 | |||||||
CHARLTON, John William Charles | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | Company Secretary | 119598150002 | ||||
COLEMAN, Patrick Joseph | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | Company Director | 259978320001 | ||||
SMITH, Peter David Mawby | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | Chief Financial Officer | 159286600001 | ||||
DWYER, Daniel John | Sekretär | Goldfinch Close Chelsfield BR6 6NF Orpington 14 Kent | British | 112335920001 | ||||||
HAYES, Chris | Sekretär | Windsor Road PR9 9DB Southport 49 Merseyside Uk | British | Accountant | 135198810001 | |||||
HOWELL, Simon John | Sekretär | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | 202440460001 | |||||||
JONES, Mark Andrew | Sekretär | 13 Rutters Lane Hazel Grove SK7 5AY Stockport Cheshire | British | Accountant | 122429790001 | |||||
KERRY, Simon | Sekretär | St Kenelm Court Steelpark Road B62 8HD Halesowen 4 West Midlands England | 150202190001 | |||||||
LLEWELLYN, Mark Stephen | Sekretär | 21 High Street Tutbury DE13 9LS Burton-On-Trent Robinia House Staffordshire | English | Accountant | 201025330001 | |||||
MCCURDY, Barry James Joseph | Sekretär | 21 Claremont Drive WA8 9LX Widnes Cheshire | British | 80677910002 | ||||||
SILK, Frances | Sekretär | Hatherton House The Old Rectory WS15 3NL Admaston Staffordshire | British | 94515450002 | ||||||
BIRRANE, Sean Thomas | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | England | British | Director | 101296120004 | ||||
BLACK, Stuart John | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 49053310001 | ||||
CORNES, Paul Stephen | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | Director | 155586570001 | ||||
CUNNINGHAM, Darren | Geschäftsführer | Fairways Walker Lane Fulwood PR2 7AP Preston Lancashire | United Kingdom | British | Marketing | 66265530004 | ||||
DWYER, Daniel James | Geschäftsführer | Clovers End Patcham BN1 8PJ Brighton 2 East Sussex | United Kingdom | British | Company Registration Agent | 86094440001 | ||||
JONES, Mark Andrew | Geschäftsführer | 13 Rutters Lane Hazel Grove SK7 5AY Stockport Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 122429790001 | ||||
KERRY, Simon | Geschäftsführer | St. Kenelm Court Steelpark Road B62 8HD Halesowen 4 West Midlands England | England | British | Director | 147820500001 | ||||
LLEWELLYN, Mark Stephen | Geschäftsführer | 21 High Street Tutbury DE13 9LS Burton-On-Trent Robinia House Staffordshire | England | English | Accountant | 201025330001 | ||||
MCMAHON, Michael | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | United Kingdom | British | Company Director | 173928090001 | ||||
SHAH, Bharat Chimanlal | Geschäftsführer | 45 Dene Road HA6 2DD Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Director | 92761250002 | ||||
SILK, Frances | Geschäftsführer | Hatherton House The Old Rectory WS15 3NL Admaston Staffordshire | England | British | Finance Director | 94515450002 | ||||
SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 187009310001 | ||||
VIITIKKO, Heikki Kalevi | Geschäftsführer | 4 Aynsley Court WA9 5GE St. Helens | Finnish | Managing Director | 72705340002 | |||||
WINKS, Nicholas Paul David | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 151282040001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SPEEDFIT LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sure Maintenance Group Limited | 30. Juni 2016 | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SPEEDFIT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 19. Dez. 2018 Geliefert am 24. Dez. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 03. Dez. 2015 Geliefert am 14. Dez. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Feb. 2012 Geliefert am 14. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A supplemental debenture | Erstellt am 18. März 2010 Geliefert am 25. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or the noteholders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The new loan notes are deemed to form part of the A1 loan notes for the purposes of the debenture see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 03. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholders (or any of them) or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 02. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. März 2005 Geliefert am 24. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of a life policy to secure own liabilities of a company | Erstellt am 22. März 2005 Geliefert am 24. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money, including bonuses, that has accrued or may become payable under the pheikki viitikko, date of policy: 15/10/04, insurer: st. James's place, policy number: 43C03P00, sum assured: £550,000 term date: 4 years; heikki viitikko, date of policy: 15/10/04, insurer: st. James's place, policy number: 43C36J57, sum assured: £1.8M term date: 2 years;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 22. März 2005 Geliefert am 24. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank, whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling;. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Juli 2004 Geliefert am 23. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0