LUMRUTH LTD
Überblick
Unternehmensname | LUMRUTH LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05158406 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LUMRUTH LTD?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LUMRUTH LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Allanadale Court Waterpark Road M7 4JN Salford Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LUMRUTH LTD?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LUMRUTH LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clifford Donald Wing als Geschäftsführer am 20. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Pearl Adler als Geschäftsführer am 20. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jacob Adler als Sekretär am 20. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Cliff Wing als Direktor am 23. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rachel Weis als Geschäftsführer am 23. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Aubrey Weis als Geschäftsführer am 23. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | MG01 | |||||||||||||||
legacy | 12 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 12 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 6 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LUMRUTH LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADLER, Jacob | Sekretär | 7 Brantwood Road M7 4EN Salford Lancashire | English | 94865510001 | ||||||
OLSBERG, Bernard | Sekretär | 2nd Floor Levi House Bury Old Road, Salford M7 4QX Manchester | British | 92195540001 | ||||||
ADLER, Pearl | Geschäftsführer | 7 Brantwood Road Salford M7 4EN Manchester | England | British | Co Director | 63198510001 | ||||
OLSBERG, Rachel Hannah | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 22 New Hall Avenue M7 4HR Salford | England | British | Secretary | 900009100001 | ||||
WEIS, Aubrey | Geschäftsführer | 1 Allanadale Court Waterpark Road M7 4JN Salford Manchester | England | British | Company Director | 9344520001 | ||||
WEIS, Rachel | Geschäftsführer | 1 Allanadale Court Waterpark Road M7 4JN Salford Manchester | England | British | Company Director | 26417370001 | ||||
WING, Clifford Donald | Geschäftsführer | 1 Allanadale Court Waterpark Road M7 4JN Salford Manchester | England | British | Company Director | 213069410001 |
Hat LUMRUTH LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2011 Geliefert am 07. Dez. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors (or either of them) to the group members (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a units 2 4 and 5 tong street business park holme lane bradford west yorkshire t/no's WYK776042,WYK756235 and WYK747699 fixed charge the benefit of all agreements,insurances see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Nov. 2011 Geliefert am 01. Dez. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the group member (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a units 2,4 and 5 tong street business park holme lane bradford yorkshire t/no's WYK776042,WYK756235 and WYK747699 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 08. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the south east of holme lane, bradford t/n WYK756235 land on the south side of holme lane, bradford t/n WYK776042 land on the south side of holme lane, bradford t/n WYK747699. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 08. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the east side of hoyle house fold, linthwaite, huddersfield t/n WYK554583 the f/h land adjoining spring grove mills, manchester road, linthwaite, huddersfield t/n WYK554939 the f/h land being 9 to 13 (odd) and the former site of 15 hoyle house fold, linthwaite, huddersfield t/n WYK475095 the f/h property being spring grove mills manchester road, linthwaite, huddersfield t/n WYK507739. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture (floating charge) | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 08. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First floating charge all property and assets, both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 31. Aug. 2004 Geliefert am 11. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Aug. 2004 Geliefert am 11. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a units 2,4 and 5 tong street business park, holme lane, bradford and land on south side of holme lane bradford t/no WYK750478 and WYK747699. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0