CELOTEX GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CELOTEX GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05162972 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CELOTEX GROUP LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich CELOTEX GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tower Bridge House St Katharine'S Way E1W 1DD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CELOTEX GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PINCO 2151 LIMITED | 25. Juni 2004 | 25. Juni 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CELOTEX GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CELOTEX GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CELOTEX GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Saint Gobain House Binley Business Park Coventry CV3 2TT zum Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD am 16. Okt. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicolas Suret als Geschäftsführer am 21. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Strickland Chaldecott als Geschäftsführer am 21. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Edward Moore als Direktor am 21. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alun Roy Oxenham als Direktor am 21. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emmanuel Du Moulin als Geschäftsführer am 21. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Stephen Chambers als Geschäftsführer am 21. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam Gilson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 3 Seiten | AUD | ||||||||||
Verschiedenes Aud sect 519 | 3 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Craig Stephen Chambers als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Adam Quincey Gilson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Goddard als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Strickland Chaldecott als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Anderson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Pemberton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von David Anderson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CELOTEX GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXENHAM, Alun | Sekretär | St Katharine's Way E1W 1DD London Tower Bridge House | British | 172155000001 | ||||||
| MOORE, Philip Edward | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom | United Kingdom | British | 60599570002 | |||||
| OXENHAM, Alun Roy | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 72478560002 | |||||
| GODDARD, Mark Sean | Sekretär | 7 Woods Walk IP5 2DG Kesgrave Suffolk | British | 72322400003 | ||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||
| ANDERSON, David | Geschäftsführer | East Leake LE12 6JS Loughborough Bpb Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 128900720001 | |||||
| CHALDECOTT, Michael Strickland | Geschäftsführer | East Leake LE12 6HX Loughborough Head Office Leicestershire United Kingdom | England | British | 126434970001 | |||||
| CHAMBERS, Craig Stephen | Geschäftsführer | Hadleigh IP7 6BA Ipswich Lady Lane Industrial Estate Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 177521000001 | |||||
| DU MOULIN, Emmanuel | Geschäftsführer | Saint Gobain House Binley Business Park CV3 2TT Coventry | United Kingdom | French | 163728500001 | |||||
| GILSON, Adam Quincey | Geschäftsführer | Binley Business Park CV3 2TT Coventry Saint-Gobain House United Kingdom | England | British | 177261700001 | |||||
| GODDARD, Mark Sean | Geschäftsführer | 7 Woods Walk IP5 2DG Kesgrave Suffolk | United Kingdom | British | 72322400003 | |||||
| HARPER, Digby John | Geschäftsführer | Roke Barn 18 Fifield Barns Benson OX10 6EZ Wallingford Oxfordshire | England | British | 26395190002 | |||||
| LONG, David Brian | Geschäftsführer | Lynne Walk KT10 9DZ Esher 2a Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 40011570003 | |||||
| MACLELLAN, Ian David | Geschäftsführer | Wormleighton Grange CV47 2XZ Southam Warwickshire | United Kingdom | British | 33693580001 | |||||
| MOXON, Paul Keith | Geschäftsführer | 60 Abington Grove NN1 4QU Northampton Northamptonshire | England | British | 151403860004 | |||||
| NEALE, Christopher James | Geschäftsführer | Castle Mews KT13 9QY Weybridge 9 Surrey | Uk | British | 133653500004 | |||||
| PEMBERTON, Richard Stratten | Geschäftsführer | 11b Noverton Lane Prestbury GL52 5BA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 116545210001 | |||||
| SURET, Nicolas | Geschäftsführer | Les Miroirs 18 Avenue D'Alsace 92400 Courbevoie Saint-Gobain Isover France | France | French | 172011450001 | |||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76332110001 |
Hat CELOTEX GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Aug. 2011 Geliefert am 09. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Aug. 2011 Geliefert am 09. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of keyman life policies | Erstellt am 21. Apr. 2005 Geliefert am 26. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Agrees to assign with full title guarantee the policies and all monies which shall become payable under it and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of keyman life policies | Erstellt am 12. Nov. 2004 Geliefert am 25. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Agrees to assign with full title guarantee the policies and all monies which shall become payable under it and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any stockholder or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 22. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at lady lane industrial estate hadleigh ipswich t/no SK214196, f/h land lying to the north west of lady of lady lane hadleigh ipswich t/no SK203174, f/h land lying to the west of lady lane hadleigh ipswich t/no SK174224. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CELOTEX GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0