TANDERON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTANDERON LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05173670
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TANDERON LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TANDERON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    43 Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    Tyne And Wear
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TANDERON LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für TANDERON LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis06. Juli 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung20. Juli 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis06. Juli 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für TANDERON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2024

    12 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2023

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2022

    10 SeitenAA

    Ernennung von Mr Lee West als Direktor am 14. Sept. 2021

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2021

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juli 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2020

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juli 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juli 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 10. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 09. Aug. 2013

    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von TANDERON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CARR, Jane Rosanna
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    Uk
    Sekretär
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    Uk
    BritishCompany Secretary81661930002
    WEST, Derek Edward
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    Uk
    Geschäftsführer
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    Uk
    United KingdomBritishDirector46680140002
    WEST, Lee
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishDirector46680150003
    ANDERTON, Brian Charles
    4 West Parade
    NE31 2TN Hebburn
    Tyne & Wear
    Sekretär
    4 West Parade
    NE31 2TN Hebburn
    Tyne & Wear
    BritishRetired99103880001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    ANDERTON, Mary
    4 West Parade
    NE31 2TN Hebburn
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    4 West Parade
    NE31 2TN Hebburn
    Tyne & Wear
    BritishManager62275320001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TANDERON LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Derek Edward West
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    06. Apr. 2016
    Maxwell Street
    NE33 4PU South Shields
    43
    Tyne And Wear
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat TANDERON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 16. Nov. 2011
    Geliefert am 17. Nov. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H flat 156 centenary mill court, new hall lane, preston, t/no: lan 8943 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 2009
    Geliefert am 17. Dez. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 47 & 49 biddlestone crescent north shields north tyneside t/n TY352447. F/h 164 & 166 verne road north tyneside t/n TY352446. L/h 5 billy mill avenue north shields north tyneside t/N393893 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees (for details of further properties charged please refer to form 395) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 09. Sept. 2009
    Geliefert am 18. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. März 2006
    Geliefert am 29. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    90 centenary mill court preston. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 29. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Okt. 2005
    Geliefert am 05. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    57 warwick road south shields tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
      • Aktenzeichen 9
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. März 2005
    Geliefert am 05. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29 centenary mill court preston. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
      • Aktenzeichen 8
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. März 2005
    Geliefert am 05. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    156 centenary mill court preston. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
      • Aktenzeichen 7
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 24. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31 derby street, jarrow, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 24. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    527 john williamson street, south shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 24. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    164 verne road, north shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 6
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 24. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7 rutland place, north shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 07. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
      • Aktenzeichen 5
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 24. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    47 biddlestone crescent, north shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 4
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    11 billy mill avenue, north shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 3
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    9 billy mill avenue, north shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 2
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    5 billy mill avenue, north shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    11/12 thorncliffe place, north shields, tyne & wear. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 08. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
      • Aktenzeichen 10
    Debenture
    Erstellt am 18. Nov. 2004
    Geliefert am 20. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat TANDERON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    5Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    6Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    7Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    8Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    9Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    Receiver Manager
    8 High Street
    Yarm
    TS15 9AE Cleveland
    10Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Harvey Madden
    Taylor Rowlands
    8 High Street
    TS15 9AE Yarm
    Stockton On Tees
    Receiver Manager
    Taylor Rowlands
    8 High Street
    TS15 9AE Yarm
    Stockton On Tees

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0