TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05173932
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MIRRORCLOSE LIMITED08. Juli 200408. Juli 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    27 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2015

    49 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SD am 23. Dez. 2014

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Dez. 2014

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 30. Juni 2014

    • Kapital: GBP 325,001
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    15 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    20 SeitenMG01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    15 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    14 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Sekretär
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    AustralianChartered Accountant57113450003
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    EnglandAustralianChartered Accountant57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor6815470021
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Sekretär
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    BritishDirector93906210001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishDirector88628480001
    LAYTON, Matthew Robert
    Nutwood House
    Wormley West End
    EN10 7QN Broxbourne
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Nutwood House
    Wormley West End
    EN10 7QN Broxbourne
    Hertfordshire
    BritishSolicitor98832270001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Geschäftsführer
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritishDirector93906210001
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer166789700001

    Hat TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Confirmatory security agreement
    Erstellt am 28. Jan. 2010
    Geliefert am 04. Feb. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security deed
    Erstellt am 19. Okt. 2004
    Geliefert am 27. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property, all buildings erections fixtures fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intercompany loans, goodwill & uncalled capital floating charge all assets not charged or assigned under the deed, all assets located in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Finance Parties(Security Agent)
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Security accession deed
    Erstellt am 09. Sept. 2004
    Geliefert am 24. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a travelodge at leigh delamere motorway service area eastbound t/no WT224069, l/h property k/a travelodge at leigh delamere motorway service area westbound t/no WT224070 and l/h property k/a travelodge at southwaite motorway service area southbound t/no CU191248. By way of first equitable mortgage all subsidiary shares and all distribution rights. By way of first fixed charge all other interests, all plant machinery vehicles computers, all monies standing to the credit of any accounts. By way of floating charge all assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed
    Erstellt am 09. Sept. 2004
    Geliefert am 18. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the travelodge at leigh delamere motorway service area eastbound t/n WT224069 l/h property k/a the travelodge at leigh delamere motorway service area eastbound t/n WT224070 l/h property k/a the travelodge at southwaite motorway service area southbound t/n CU191248. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Leveraged debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2003
    Erworben am 09. Sept. 2004
    Geliefert am 29. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For details of specific property acquired please refer to schedule 4 attached to form 400). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Term debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2003
    Erworben am 09. Sept. 2004
    Geliefert am 21. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all f/h and l/h property, together with all buildings and fixtures, all the subsidiary shares and all corresponding distribution rights, the buildings and fixtures (including trade fixtures), all plant, machinery, vehicles, computers, office and other equipment, by way of first floating charge all its assets, both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Dez. 2014Beginn der Liquidation
    30. Dez. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Neil David Gostelow
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0