TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05173932 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Berkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MIRRORCLOSE LIMITED | 08. Juli 2004 | 08. Juli 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 27 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2015 | 49 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SD am 23. Dez. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 20 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMM, Sandra Louise | Sekretär | Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Kpmg Llp Berkshire | Australian | Chartered Accountant | 57113450003 | |||||
GUMM, Sandra Louise | Geschäftsführer | Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Kpmg Llp Berkshire | England | Australian | Chartered Accountant | 57113450003 | ||||
LESLAU, Nicholas Mark | Geschäftsführer | Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Kpmg Llp Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 6815470021 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Sekretär | Southdown Lodge 43 The Downs Wimbledon SW20 8HE London | British | Director | 93906210001 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
HEARN, Grant David | Geschäftsführer | Bishops Platt Norlands Lane TW20 8SS Thorpe Surrey | United Kingdom | British | Director | 88628480001 | ||||
LAYTON, Matthew Robert | Geschäftsführer | Nutwood House Wormley West End EN10 7QN Broxbourne Hertfordshire | British | Solicitor | 98832270001 | |||||
MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | Southdown Lodge 43 The Downs Wimbledon SW20 8HE London | United Kingdom | British | Director | 93906210001 | ||||
PUDGE, David John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 20 Herondale Avenue SW18 3JL London | British | 900028170001 | ||||||
TURNER, Harry | Geschäftsführer | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | Chief Operating Officer | 166789700001 |
Hat TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Confirmatory security agreement | Erstellt am 28. Jan. 2010 Geliefert am 04. Feb. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security deed | Erstellt am 19. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property, all buildings erections fixtures fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intercompany loans, goodwill & uncalled capital floating charge all assets not charged or assigned under the deed, all assets located in scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed | Erstellt am 09. Sept. 2004 Geliefert am 24. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a travelodge at leigh delamere motorway service area eastbound t/no WT224069, l/h property k/a travelodge at leigh delamere motorway service area westbound t/no WT224070 and l/h property k/a travelodge at southwaite motorway service area southbound t/no CU191248. By way of first equitable mortgage all subsidiary shares and all distribution rights. By way of first fixed charge all other interests, all plant machinery vehicles computers, all monies standing to the credit of any accounts. By way of floating charge all assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed | Erstellt am 09. Sept. 2004 Geliefert am 18. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a the travelodge at leigh delamere motorway service area eastbound t/n WT224069 l/h property k/a the travelodge at leigh delamere motorway service area eastbound t/n WT224070 l/h property k/a the travelodge at southwaite motorway service area southbound t/n CU191248. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Leveraged debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Erworben am 09. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (For details of specific property acquired please refer to schedule 4 attached to form 400). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Term debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Erworben am 09. Sept. 2004 Geliefert am 21. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all f/h and l/h property, together with all buildings and fixtures, all the subsidiary shares and all corresponding distribution rights, the buildings and fixtures (including trade fixtures), all plant, machinery, vehicles, computers, office and other equipment, by way of first floating charge all its assets, both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TLLC BRIDGESUBCO5 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0