COILBAY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COILBAY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05176330 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COILBAY LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich COILBAY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Leonard Curtis House, Elms Square Bury New Road Whitefield M45 7TA Greater Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COILBAY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COILBAY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 19 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Juli 2022 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Old Heath Road Wolverhampton Wolverhampton West Midlands WV1 2QT zum Leonard Curtis House, Elms Square Bury New Road Whitefield Greater Manchester M45 7TA am 05. Aug. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 9 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Theodore Berenzweig am 13. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Dryden am 13. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Georg Heinrich Johannes Strierath am 13. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktualisierung der Informationen des Gesellschafterverzeichnisses im öffentlichen Register | 6 Seiten | EH06 | ||||||||||
Notification of The Goldman Sachs Group Inc as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 4 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Wählen Sie, die Informationen des Verzeichnisses der Personen mit maßgeblichem Einfluss im öffentlichen Register zu führen | 2 Seiten | EH04 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jayne Evelyn Williams als Sekretär am 12. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COILBAY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Jayne Evelyn | Sekretär | Bury New Road Whitefield M45 7TA Greater Manchester Leonard Curtis House, Elms Square | 231972170001 | |||||||
| BERENZWEIG, Jeremy Theodore | Geschäftsführer | Old Heath Road WV1 2QT Wolverhampton Flint Group Works West Midlands United Kingdom | England | British | 130485700002 | |||||
| DRYDEN, Stephen | Geschäftsführer | Old Heath Road WV1 2QT Wolverhampton Flint Group Works West Midlands United Kingdom | England | British | 231621730002 | |||||
| STRIERATH, Georg Heinrich Johannes | Geschäftsführer | Old Heath Road WV1 2QT Wolverhampton Flint Group Works West Midlands United Kingdom | Germany | German | 194506770011 | |||||
| CONNELL, John Gregory | Sekretär | 2 Larch Rise Prestbury SK10 4UY Macclesfield Cheshire | British | 16795230001 | ||||||
| FOXLEY, Russell Barry James | Sekretär | Stane Street Slinfold RH13 0SH Horsham West Sussex | British | 126099560001 | ||||||
| GODFREY, Stephen Richard | Sekretär | Hardtstr D-71711 Steinheim An Der Murr 12 Germany | 157868750001 | |||||||
| SHARMAN, Alistair Richard Norris | Sekretär | Wolverhampton WV1 2QT Wolverhampton Old Heath Road West Midlands | 184435510001 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| BISSELL, Michael John | Geschäftsführer | 16 Leadhall Grove HG2 9ND Harrogate North Yorkshire | England | British | 72109080004 | |||||
| CONNELL, John Gregory | Geschäftsführer | Northbank Industrial Park M44 5BL Irlam Varn House Greater Manchester United Kingdom | Uk | British | 16795230001 | |||||
| GODFREY, Stephen Richard | Geschäftsführer | Wolverhampton WV1 2QT Wolverhampton Old Heath Road West Midlands | Germany | British | 157863660001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Geschäftsführer | Nutwood House Wormley West End EN10 7QN Broxbourne Hertfordshire | British | 98832270001 | ||||||
| NIEBERDING, Sean Alexander | Geschäftsführer | Wieland Strasse 10 Frankfurt Am Main FOREIGN Germany D-60318 | American | 100631580001 | ||||||
| POULSON, Howard | Geschäftsführer | Field Gap Trip Garth LS22 4HY Linton Wetherby West Yorkshire | British | 37394840002 | ||||||
| PUDGE, David John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 20 Herondale Avenue SW18 3JL London | British | 900028170001 | ||||||
| SHARMAN, Alistair Richard Norris | Geschäftsführer | Wolverhampton WV1 2QT Wolverhampton Old Heath Road West Midlands | United Kingdom | British | 253658340001 | |||||
| WILDMOSER, Christian | Geschäftsführer | Route De Jorat 16 Savigny FOREIGN Switzerland 1073 | Austrian | 100630490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COILBAY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group Inc | 06. Apr. 2016 | West Street Ny 10282 New York 200 United States | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| The Goldman Sachs Group, Inc | 06. Apr. 2016 | West Street Ny 10282, New York 200 United States | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat COILBAY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 17. März 2011 Geliefert am 30. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Mai 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All real property, all plant and machinery equipment computers vehicles and other chattels, all charged deposits, all investments and shares and all related rights, all rights title interests and benefits in to or in respect of the insurances and all claims, any interest claim or entitlement in to or in respect of any pension fund, goodwill uncalled capital and intellectual proeprty rights. By way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A bank account assignment | Erstellt am 30. Sept. 2005 Geliefert am 13. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the senior finance parties, the tranche d lenders and the mezzanine finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing bank account assignments the deposit to the security agent. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2005 Geliefert am 13. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the real property plant machinery and equipment charged deposits the insurances and all claims the goodwill of the company floating charge all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bank account assignment | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben With full title guarantee the deposit being the balance standing to the credit of the accounts numbered 32172101 and 32172102,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Dez. 2004 Geliefert am 10. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat COILBAY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0