PEAKSHIELD LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PEAKSHIELD LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05178010 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PEAKSHIELD LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PEAKSHIELD LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor 7-10 Chandos Street W1G 9DQ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PEAKSHIELD LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PEAKSHIELD LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PEAKSHIELD LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gerard Murphy als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Hill Street Registrars Limited am 01. März 2013 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 7-10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ* am 30. Jan. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jacqueline Cremin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Gerard Marian Murphy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2008 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2007 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 10 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PEAKSHIELD LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILL STREET REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Floor 7/10 Chandos Street W1G 9DQ London 4th United Kingdom | 2417910005 | |||||||
| MOSS, Roger Samuel | Geschäftsführer | Bolton Street Mayfair WI7 8BP London 28 | United Kingdom | British | 101312720004 | |||||
| SCHILD, Annabel Martha | Geschäftsführer | 11 Elm Tree Road NW8 9JY London | United Kingdom | British | 120537680001 | |||||
| SCHILD, Daphne | Sekretär | 5 Byron Drive Bishops Avenue N2 0BD London | British | 82371180001 | ||||||
| SDG SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 41 Chalton Street NW1 1JD London | 900028430001 | |||||||
| CREMIN, Jacqueline | Geschäftsführer | 15 Princeton Ardilea IRISH Clonskeagh Dublin 4 Republic Of Ireland | Irish | 107995720001 | ||||||
| HIGGINS, Bryan | Geschäftsführer | 41 Radcliff Hall, St John's Road IRISH Sandymount Dublin 4 Ireland | Irish | 100596100001 | ||||||
| MURPHY, Gerard Marian | Geschäftsführer | Elgin Road Ballsbridge 1 Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | 148956400001 | |||||
| PARNES, Anthony Keith | Geschäftsführer | 5a Mount Street W1K 3NE London | British | 100253670001 | ||||||
| SDG REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 41 Chalton Street NW1 1JD London | 900028420001 |
Hat PEAKSHIELD LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Erstellt am 22. Juni 2007 Geliefert am 12. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors and/or the beneficiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a the derby hotel 155-157 cromwell road london t/nos LN110758 and LN109729, f/h land and buildings k/a 36A glebe place london t/no NGL364315 and f/h land and buildings k/a 48 old church street london t/no NGL142406. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. März 2006 Geliefert am 30. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that l/h property k/a 48 old church street london t/n NGL142406 all the f/h or l/h property and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Sept. 2004 Geliefert am 01. Okt. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a 48 old church street, london t/no NGL142406 by way of fixed charge all plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment now from time to time the goodwill of any business carried on. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. Sept. 2004 Geliefert am 24. Sept. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Sept. 2004 Geliefert am 24. Sept. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 48 old church street, chelsea, london, t/no NGL142406 and all that l/h property k/a lower ground floor level. 48 old church street, chelsea, london, t/no bgl 23042 and including all rights and all buildings situate on it. The charged property also includes property assets, debts, rights and goodwill.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0