POULTER MARKETING GROUP LIMITED

POULTER MARKETING GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePOULTER MARKETING GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05188168
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Rose Wharf
    East Street
    LS9 8EE Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INHOCO 3106 LIMITED23. Juli 200423. Juli 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    5 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Aug. 2011

    Kapitalaufstellung am 08. Aug. 2011

    • Kapital: GBP 939,938
    SH01

    legacy

    18 SeitenMG01

    Ernennung von Mr Trevor John O'reilly als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Gary Knights als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    18 SeitenMG01

    Beendigung der Bestellung von Mark Shaw als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Richard Timothy Barfield als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Richard Timothy Barfield als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Shaw als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    8 SeitenAA

    legacy

    15 SeitenMG01

    Beendigung der Bestellung von William Ronald als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    7 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von POULTER MARKETING GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    157835390001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish123477010001
    O'REILLY, Trevor John
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    IrelandIrish148130760001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Sekretär
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    British129305300001
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Sekretär
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    British105115960001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Sekretär
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British103609160001
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    British107353690001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BUCKLE, Mark Raymond
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree Cottage
    Mickley
    HG4 3JE Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish121880340001
    COLTON HAWKINS, Darren John
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Sheardale
    Honley
    HD9 6RU Huddersfield
    West Yorkshire
    British100773780001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    EnglandBritish129305300001
    GORING, Nicholas Francis
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Holly Park
    Huby
    LS17 0BT Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish100773750001
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritish45695650002
    LEACH, Ian
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    Geschäftsführer
    Church Farmhouse
    Claypit Lane, Ledsham
    LS25 6NB Leeds
    United KingdomBritish105115960001
    MCCALL, Gary William
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Homestead Cottage Foxen Lane
    Mill Bank
    HX6 3EQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish59547330001
    RIVETT JONES, Peter
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 High Street
    Spofforth
    HG3 1BQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish112998390001
    RONALD, William David Gordon
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritish138299060001
    SAVAGE, Michael James
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lane Ends
    Midgehole Road
    HX7 7AL Hebden Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish103609160001
    SAXBY, Mark Kenneth Baber
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fairburns Farmhouse
    Wath
    HG4 5EJ Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish59543920002
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107353690001
    TOYNTON, Peter Anthony
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Stable Court
    Picts Lane,
    RH13 8AW Cowfold
    West Sussex
    United KingdomBritish9723050002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    PEMBRIDGE PARTNERS LLP
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    85753460001

    Hat POULTER MARKETING GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security confirmation and supplemental deed
    Erstellt am 13. Juni 2011
    Geliefert am 17. Juni 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A security confirmation and supplemental deed
    Erstellt am 24. Feb. 2011
    Geliefert am 08. März 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Charged by way of fixed charge all shares all related distribution rights all investment and all related distribution rights all book debts and all benefits rights and security held in respect of or to secure the payment of the book debts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A confirmatory deed
    Erstellt am 18. Dez. 2009
    Geliefert am 04. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    A confirmatory deed
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 14. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Confirmatory deed supplemental to a debenture originally dated 19 august 2005 and
    Erstellt am 17. März 2009
    Geliefert am 25. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 20. März 2008
    Geliefert am 10. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Security accession deed
    Erstellt am 15. Sept. 2006
    Geliefert am 27. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustees for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Okt. 2004
    Geliefert am 16. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the holders of the loan stock 2006 or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Johnstone Limited (Security Trustee as Trustee for Each of the Holders of the Loan Stock)
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Okt. 2004
    Geliefert am 12. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0