ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED

ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05209530
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED?

    • See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Finsbury Circus
    EC2M 7SH London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INSTALLER OFFSHORE LIMITED18. Aug. 200418. Aug. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 31. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Graham Alexander Dale am 01. Aug. 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Graham Alexander Dale am 01. Aug. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 19. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sh Company Secretaries Limited am 19. Aug. 2013

    1 SeitenCH04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Aug. 2011

    14 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sh Company Secretaries Limited am 09. Apr. 2011

    3 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * One St. Paul's Churchyard London EC4M 8SH* am 18. Apr. 2011

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Aug. 2010

    15 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009

    5 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    legacy

    8 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    11 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SH COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Finsbury Circus
    EC2M 7SH London
    1
    United Kingdom
    Sekretär
    Finsbury Circus
    EC2M 7SH London
    1
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03552496
    85597290003
    DALE, Graham Alexander
    Norfolk Road
    AB10 6JR Aberdeen
    33
    Aberdeenshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Norfolk Road
    AB10 6JR Aberdeen
    33
    Aberdeenshire
    Scotland
    United KingdomBritish139488940002
    STAKKESTAD, Sven
    Brakeveien 51
    Kopervik
    N4250
    Norway
    Geschäftsführer
    Brakeveien 51
    Kopervik
    N4250
    Norway
    NorwayNorwegian62575140001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Sekretär
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Other95892040003
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Sekretär
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    BRIGHTON SECRETARY LTD
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    Bevollmächtigter Sekretär
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    900023320001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Geschäftsführer
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOther95892040003
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Geschäftsführer
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritish72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Geschäftsführer
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritish83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Geschäftsführer
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritish99475270002
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Geschäftsführer
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    British72665990003
    BRIGHTON DIRECTOR LTD
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    3 Marlborough Road
    Lancing Business Park
    BN15 8UF Lancing
    West Sussex
    900023310001

    Hat ADVANCED DEEP SEA INSTALLER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Proceeds deposit account agreement
    Erstellt am 21. Nov. 2008
    Geliefert am 24. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the proceeds deposit account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Ship mortgage deed
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 19. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from allco finance (UK) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The ship with name "normand installer" signal letters "LAE06" entered in the norwegian international ship register with home port of skudeneshavn and appurtenances of whatever kind and the proceeds of all insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V.
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority deed of assignment of insurances and requisition compensation
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 20. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from allco finance (UK) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the respective rights title and interest present and future of the owner and the partnership in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sbm Offshore N.V.
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Third priority norwegian ship mortgage deed
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 20. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from allco finance UK limited and the advanced deep sea installer limited partnership and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel normand installer comprising the various parts and appurtenances of the ship of whatever kind including future acquisitions and the proceeds of all insurance sums for the vessel.
    Berechtigte Personen
    • Sbm Offshore N.V.
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A second priority deed of general assignment and covenant
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 06. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The companys right title and interest present and future in and to all policies and contracts of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb General Leasing (No.1) Limited (the Assignee)
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A first ranking deed of general assignment
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the sponsor to any beneficiary (and payable to the chargee for the account of the beneficiaries) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge a) the owner account balances and all its rights in respect of any owner account balances standing to the credit of the owner account b) all book and other debts, the proceeds of the same and all other moneys due or owing and the benefit of all rights securities and guarantees. Assigns all rights title and interest in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bank N.V. (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0