KBC HARROW LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KBC HARROW LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05214729 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KBC HARROW LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich KBC HARROW LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6th Floor, 2 Kingdom Street W2 6BD London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KBC HARROW LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KBC HARROW LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Burwood Place London W2 2UT England zum 6th Floor, 2 Kingdom Street London W2 6BD am 14. Aug. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Oliver Loh als Geschäftsführer am 12. Mai 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 2 Seiten | AA | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 2 Seiten | AA | ||||||
Eintragung der Belastung 052147290007, erstellt am 31. Dez. 2020 | 32 Seiten | MR01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 17 Seiten | AA | ||||||
Eintragung der Belastung 052147290006, erstellt am 20. Okt. 2020 | 4 Seiten | MR01 | ||||||
Ernennung von Mr Simon Oliver Loh als Direktor am 06. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Peter David Edward Gibson als Geschäftsführer am 28. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 18 Seiten | AA | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||
legacy | 10 Seiten | RP04CS01 | ||||||
Cessation of Kbc Holdings Limited as a person with significant control on 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||
Notification of Iwg Plc as a person with significant control on 19. Dez. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||
| ||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KBC HARROW LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, Richard | Geschäftsführer | 2 Kingdom Street W2 6BD London 6th Floor, England | England | British | 190653350001 | |||||
| ALEXANDER, Paul | Sekretär | Long Acre WC2E 9LY London 22 England | 183191770001 | |||||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Sekretär | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | British | 73690140002 | ||||||
| CORT, Louise | Sekretär | 7a Ellerton Road Earlsfield SW18 3NG London | British | 84863600003 | ||||||
| EDWARDS, Marie Elizabeth | Sekretär | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | 185457880001 | |||||||
| SAVANI, Iqbal | Sekretär | 18 Berry Hill HA7 4XS Stanmore Middlesex | British | 96895020001 | ||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Sekretär | Long Acre WC2E 9LY London 22 England | 154659950001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALEXANDER, Paul Andrew | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 97550550001 | |||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Geschäftsführer | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | United Kingdom | British | 73690140002 | |||||
| GIBSON, Peter David Edward | Geschäftsführer | Burwood Place W2 2UT London 1 England | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||
| KINGSHOTT, Michael James | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 83713020002 | |||||
| LOH, Simon Oliver | Geschäftsführer | Burwood Place W2 2UT London 1 England | United Kingdom | British | 197301770002 | |||||
| PEPPER, Alan Douglas | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 98245120002 | |||||
| PRINGLE, Aileen | Geschäftsführer | 12 Belgrave Crescent EH4 3AH Edinburgh | United Kingdom | British | 764870001 | |||||
| SAVANI, Iqbal | Geschäftsführer | 18 Berry Hill HA7 4XS Stanmore Middlesex | British | 96895020001 | ||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | Long Acre WC2E 9LY London 22 England | England | British | 154659960001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KBC HARROW LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwg Plc | 19. Dez. 2016 | Grenville Street JE4 8PX St Helier 22 Jersey | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Regus Plc | 31. Okt. 2016 | Grenville Street JE4 8PX St Helier 22 | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Kbc Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat KBC HARROW LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 31. Dez. 2020 Geliefert am 18. Jan. 2021 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Okt. 2020 Geliefert am 27. Okt. 2020 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 2 gayton road, middlesex t/no NGL571767 by way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. 2 grayton road, middlesex t/no NGL571767 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 28. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Okt. 2004 Geliefert am 02. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 2 gayton road,harrow t/no NGL571767. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Okt. 2004 Geliefert am 28. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0