KBC KINGSTON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKBC KINGSTON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05214860
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KBC KINGSTON LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich KBC KINGSTON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    268 Bath Road
    SL1 4DX Slough
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KBC KINGSTON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KBC KINGSTON LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für KBC KINGSTON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Lyric Square London W6 0NB England zum 268 Bath Road Slough SL1 4DX am 23. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Richard Morris als Direktor am 10. Apr. 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Peter David Edward Gibson als Direktor am 10. Apr. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael James Kingshott als Geschäftsführer am 10. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Marie Elizabeth Edwards als Sekretär am 10. Apr. 2015

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 22 Long Acre London WC2E 9LY zum 268 Bath Road Slough SL1 4DX am 26. Nov. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    19 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Marie Elizabeth Edwards als Sekretär am 18. Dez. 2013

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Alexander als Sekretär am 18. Dez. 2013

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Paul Alexander als Direktor am 17. Okt. 2013

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Alexander als Sekretär am 17. Okt. 2013

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Alan Douglas Pepper als Direktor am 17. Okt. 2013

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Jane Scannell als Geschäftsführer am 17. Okt. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Jane Scannell als Geschäftsführer am 17. Okt. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Jane Scannell als Sekretär am 17. Okt. 2013

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Serviced Office Group 22 Long Acre London WC2E 9LY England am 29. Aug. 2013

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von KBC KINGSTON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    GIBSON, Peter David Edward
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    MORRIS, Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish190653350001
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    ALEXANDER, Paul
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Sekretär
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183186590001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Sekretär
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    CORT, Loiuse
    7a Ellerton Road
    SW18 3NG London
    Sekretär
    7a Ellerton Road
    SW18 3NG London
    British99786980001
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    Sekretär
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    185459130001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Sekretär
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    154661320001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    KINGSHOTT, Michael James
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    Geschäftsführer
    Lyric Square
    W6 0NB London
    1
    England
    EnglandBritish83713020002
    PRINGLE, Aileen
    12 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    Geschäftsführer
    12 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    United KingdomBritish764870001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Geschäftsführer
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    EnglandBritish154659960001

    Hat KBC KINGSTON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2013
    Geliefert am 12. Feb. 2013
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    20 canbury passage kingsgate road surrey t/no SY279853 together with all fixtures & fittings, now or at any time hereafter, on the property. The benefits of all rights, licences & the goodwill of the mortgagor in relation to the business, from time to time, carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Canbury passage, kingsgate road, surrey t/no's SY327216, SG1254907, SGL124369 and SGL58811. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Canbury passage, kingsgate road, surrey t/no's SY327216, SGL1254907, SGL124369 and SGL58811 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 28. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    Berechtigte Personen
    • West Register Number 2 Limited
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 2004
    Geliefert am 02. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 12-50 kingsgate road,kingston t/no's SY279853,SY327216,SGL254907,SGL124369 and SGL58811. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Okt. 2004
    Geliefert am 28. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0