JP BIDCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | JP BIDCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05221235 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JP BIDCO LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich JP BIDCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Fifth Floor 100 Wood Street EC2V 7EX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JP BIDCO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SOUTHERN CROSS BIDCO LIMITED | 03. Sept. 2004 | 03. Sept. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JP BIDCO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für JP BIDCO LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für JP BIDCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 31. Mai 2016 | 23 Seiten | 1.3 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 21 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 20 North Audley Street London W1K 6WE United Kingdom zum Fifth Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX am 07. Juni 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Juni 2015 | 23 Seiten | 1.3 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed southern cross bidco LIMITED\certificate issued on 09/06/15 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Charles Lovett als Geschäftsführer am 05. Mai 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Juni 2014 | 21 Seiten | 1.3 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 19. Juni 2013 | 25 Seiten | 1.3 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Southgate House, Archer Street Darlington County Durham DL3 6AH* am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Bolot als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Buchan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von JP BIDCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Sekretär | Park Avenue New York 345 Ny 10154 United States | American | 94259330002 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158661640001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | Park Avenue New York 345 Ny 10154 United States | Usa | American | 94259330002 | |||||
| BLITZER, David Scott | Geschäftsführer | 5 Priory Walk SW10 9SP London | England | American | 82685720001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| LOVETT, David Charles | Geschäftsführer | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | 34419700002 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| RUTTER, Christopher | Geschäftsführer | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| TOOTH, Matthew David | Geschäftsführer | Flat 6 21 Cranley Gardens SW7 3BD London | England | British | 100150000001 |
Hat JP BIDCO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 29. Feb. 2008 Geliefert am 14. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juni 2007 Geliefert am 19. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 20. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of assignment | Erstellt am 04. Nov. 2005 Geliefert am 17. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The benefit of all of its ashbourne acquisition documents claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Apr. 2005 Geliefert am 15. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2004 Geliefert am 28. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat JP BIDCO LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0