GERONIMO AIRPORTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GERONIMO AIRPORTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05237033 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GERONIMO AIRPORTS LIMITED?
- Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe
Wo befindet sich GERONIMO AIRPORTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 9th Floor 25 Farringdon Street EC4A 4AB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GERONIMO AIRPORTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GERONIMO AIRPORT LIMITED | 21. Sept. 2004 | 21. Sept. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GERONIMO AIRPORTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GERONIMO AIRPORTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Riverside House 26 Osiers Road Wandsworth London SW18 1NH zum 9th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB am 15. Jan. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Patrick Anthony Dardis am 10. Mai 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. März 2016 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Wright Whitehead als Geschäftsführer am 06. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven Allan Robinson als Direktor am 15. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Patrick Anthony Dardis als Direktor am 25. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. März 2015 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward James Turner als Geschäftsführer am 24. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 6 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 5 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2013 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rupert Clevely als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 67 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von GERONIMO AIRPORTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHROEDER, Anthony Ian | Sekretär | 25 Farringdon Street EC4A 4AB London 9th Floor | British | 156552190001 | ||||||
DARDIS, Patrick Anthony | Geschäftsführer | 25 Farringdon Street EC4A 4AB London 9th Floor | England | Irish | Retail Director | 91548000007 | ||||
ROBINSON, Steven Allan | Geschäftsführer | 25 Farringdon Street EC4A 4AB London 9th Floor | England | British | Head Of Finance | 212256850001 | ||||
BIGHAM, Conrad James | Sekretär | Homerton Lodge Heartenoak Road TN18 5EU Hawkhurst Kent | British | Consultant | 80206550002 | |||||
DYSON, Polly Jane | Sekretär | 81 Mallinson Road SW11 1BJ London | British | Accountant | 161237340001 | |||||
CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Sekretär | 22 Melton Street NW1 2BW London | 38636470004 | |||||||
BIGHAM, Conrad James | Geschäftsführer | Homerton Lodge Heartenoak Road TN18 5EU Hawkhurst Kent | United Kingdom | British | Consultant | 80206550002 | ||||
CLEVELY, Rupert John | Geschäftsführer | Tanners River GU28 9AY Petworth West Sussex | England | British | Cha Md | 13482650002 | ||||
DYSON, Polly Jane | Geschäftsführer | 81 Mallinson Road SW11 1BJ London | England | British | Director | 161237340001 | ||||
TURNER, Edward James | Geschäftsführer | 26 Osiers Road Wandsworth SW18 1NH London Riverside House England | England | British | Director | 201076350001 | ||||
WHITEHEAD, Peter Wright | Geschäftsführer | 26 Osiers Road Wandsworth SW18 1NH London Riverside House England | United Kingdom | British | Finance Director | 51144670002 | ||||
LEA YEAT LIMITED | Geschäftsführer | 22 Melton Street NW1 2BW London | 38636460001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GERONIMO AIRPORTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young & Co.'s Brewery, P.L.C, | 06. Apr. 2016 | 26 Osiers Road SW18 1NH Wandsworth Riverside House London England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat GERONIMO AIRPORTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Erstellt am 30. März 2011 Geliefert am 08. Apr. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge all assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 30. März 2011 Geliefert am 08. Apr. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge all assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 07. Juli 2009 Geliefert am 18. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 07. Juli 2009 Geliefert am 18. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, shares and investments see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Nov. 2006 Geliefert am 06. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 2006 Geliefert am 04. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The land, all shares and related distribution rights, all investments and related distribution rights, all book debts, non trading debts and all amounts standing to the credit of each proceeds account, all intellectual property rights, its goodwill, uncalled capital and floating charge all business, undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat GERONIMO AIRPORTS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0