ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameARGYLL HOMES SOUTH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05247484
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED?

    • Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen

    Wo befindet sich ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Johnston Carmichael Llp
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FLEETNESS 377 LIMITED01. Okt. 200401. Okt. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Änderung der Details des Direktors für Ian Macdonald am 27. Juni 2018

    2 SeitenCH01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3TT zum Johnston Carmichael Llp 107-111 Fleet Street London EC4A 2AB am 15. Mai 2017

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Apr. 2017

    LRESSP

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Juni 2016

    10 SeitenAA

    legacy

    35 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 30. Juni 2015

    9 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    35 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Änderung der Details des Direktors für Mr Alexander James Grant am 07. Jan. 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FRASER, George Gabriel
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Johnston Carmichael Llp
    Geschäftsführer
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Johnston Carmichael Llp
    ScotlandBritishDirector50219540001
    GRANT, Alexander James
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Johnston Carmichael Llp
    Geschäftsführer
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Johnston Carmichael Llp
    United KingdomBritishDirector113195780003
    MACDONALD, Ian
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Johnston Carmichael Llp
    Geschäftsführer
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Johnston Carmichael Llp
    ScotlandBritishQuantity Surveyor81926330001
    CAMERON, James
    C/O Field Fisher Waterhouse
    35 Vine Street
    EC3N 2AA London
    Sekretär
    C/O Field Fisher Waterhouse
    35 Vine Street
    EC3N 2AA London
    167091120001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    Sekretär
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    BritishSolicitor87534020003
    P & P SECRETARIES LIMITED
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    Lancashire
    79571340001
    BRAZIER, Stephen Harvey
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director100183520001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Geschäftsführer
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritishChartered Surveyor34848670001
    DAWES, Christopher Stephen
    48 Mada Road
    BR6 8HQ Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    48 Mada Road
    BR6 8HQ Orpington
    Kent
    EnglandBritishDirector85503000001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Geschäftsführer
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    BritishCompany Director107801990001
    MONKS, Charles
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    Geschäftsführer
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector62550910001
    MUIR, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Inverness Shire
    Geschäftsführer
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Inverness Shire
    BritishHr Director116141930001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Geschäftsführer
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritishAccountant1321720003
    P & P DIRECTORS LIMITED
    Deansgate
    M3 2BU Manchester
    123
    Geschäftsführer
    Deansgate
    M3 2BU Manchester
    123
    79571330001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    06. Apr. 2016
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc207479
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over shares
    Erstellt am 30. Apr. 2010
    Geliefert am 14. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the shares being the original shares together with all other shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 07. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 2007
    Geliefert am 11. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 26 beech grove epsom do. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 2007
    Geliefert am 07. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H broxholme, camden road, lingfield, surrey t/n SY173925. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 28 beech grove epsom downs surrey t/nos sy 594011 and sy 593794. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2007
    Geliefert am 27. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 27 beech grove epsom downs surrey t/no sy 744731. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 2007
    Geliefert am 27. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 29 beech grove epsom downs surrey t/no sy 182480. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Aug. 2006
    Geliefert am 01. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a debtor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H properties k/a 8 and 10 perryfield road crawley west sussex t/no WSX37299 and WSX81399. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Aug. 2006
    Geliefert am 22. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the debtor to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h/l/h property k/a little stanfords town hill lingfield surrey t/n SY402026. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 19. Sept. 2005
    Geliefert am 04. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Aug. 2005
    Geliefert am 08. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a st cross grange st cross winchester. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 2005
    Geliefert am 18. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All f/h property k/a hexted motors main road edenbridge kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Aug. 2005
    Geliefert am 09. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as land adjoining lowsley farm,near the avenue,liphook,hampshire GU30 7QD; t/nos SH10156 and SH18178. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat ARGYLL HOMES SOUTH LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Apr. 2017Beginn der Liquidation
    08. Sept. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew Purdon Henderson
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    Praktiker
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0