INFINIS FINANCE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | INFINIS FINANCE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05256841 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INFINIS FINANCE LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich INFINIS FINANCE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INFINIS FINANCE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WRG FINANCE PLC | 09. Dez. 2004 | 09. Dez. 2004 |
| TRUSHELFCO (NO.3104) LIMITED | 12. Okt. 2004 | 12. Okt. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INFINIS FINANCE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für INFINIS FINANCE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für INFINIS FINANCE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Samantha Jane Calder als Sekretär am 18. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 15 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Sept. 2014 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Sept. 2013 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom First Floor 500 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton Northamptonshire NN4 7YJ am 04. Okt. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Dr Eric Philippe Marianne Machiels als Direktor am 25. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Neville Hardman als Geschäftsführer am 25. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Sept. 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | CERT10 | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 17 Seiten | MAR | ||||||||||
Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | RR02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Gordon Alexander Boyd als Direktor am 12. März 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Jane Aikman als Geschäftsführer am 12. März 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Steven Neville Hardman als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INFINIS FINANCE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYD, Gordon Alexander | Geschäftsführer | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | England | British | 148856600001 | |||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne, Dr | Geschäftsführer | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | United Kingdom | Belgium | 125748990001 | |||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Sekretär | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||
| CALDER, Samantha Jane | Sekretär | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | British | 75830790003 | ||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Sekretär | Toft Hill Toft Dunchurch CV22 6NR Rugby Warwickshire | British | 93743250007 | ||||||
| WATERHOUSE, Alan | Sekretär | 2a Norwood Grove Birkenshaw BD11 2NP Bradford West Yorkshire | British | 24588340001 | ||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| TRUSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | First Floor 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| BANGA, Tavraj Singh | Geschäftsführer | c/o Terra Firma More London Riverside SE1 2AP London 2 United Kingdom | United Kingdom | Indian | 158940760001 | |||||
| CASSELLS, Leslie James Davidson | Geschäftsführer | Bridge Cottage 6 Hodges Lane NN7 4AJ Kislingbury Northamptonshire | British | 95347040001 | ||||||
| CHADD, Andrew Peter | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AP London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 133578890002 | |||||
| DARRAGH, Michael Damian | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AP London 2 | United Kingdom | British | 112146050001 | |||||
| HARDMAN, Steven Neville | Geschäftsführer | First Floor 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton Northamptonshire | Uk | British | 93743250007 | |||||
| JOHNSTON, Kevin David | Geschäftsführer | The Hermitage Chapel Loke NR14 7AQ Norwich Norfolk | British | 101299510001 | ||||||
| MEREDITH, James Robert | Geschäftsführer | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West 900 Northamptonshire | British | 29339860005 | ||||||
| PRIOR, Ruth Catherine | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AP London 2 England | United Kingdom | British | 92539490002 | |||||
| SNELL, Philip Charles | Geschäftsführer | 3 Clavering Avenue Barnes SW13 8DX London | British | 82552990002 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Geschäftsführer | More London Riverside SE1 2AP London 2 | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEWART, Quentin Richard | Geschäftsführer | 62 Anchor Brew House Shad Thames SE1 2LY London | United Kingdom | British | 94880800002 | |||||
| STOKER, Louise Jane | Geschäftsführer | 2nd Floor Flat 45 Hillfield Road, West Hampstead NW6 1QD London | British | 96079800001 | ||||||
| ZUERCHER, Eleanor Jane | Geschäftsführer | 14 St Marys Court Tingewick MK18 4RE Buckingham Buckinghamshire | British | 61053330001 |
Hat INFINIS FINANCE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Erstellt am 15. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the second secured note creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of second fixed charge all of its rights, title and interests attaching to or relating to the investments now or subsequently belonging to it, including, without limitation, the debts represented thereby and the right to repayment of all principal, premium (if any), interest and other moneys payable in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 15. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each obligor to the fixed rate note creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of third fixed charge all of its rights, title and interests attaching to or relating to the investments now or subsequently belonging to it, including, without limitation, the debts represented thereby and the right to repayment of all principal, premium (if any), interest and other moneys payable in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of third party charge | Erstellt am 15. Dez. 2004 Geliefert am 21. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all of its rights, title and interests attaching to or relating to the investments (including without limitation the acquiisitions shares and the acquisitions loan notes, including, without limitation, the debts represented thereby and the right to payment of all principal, premium (if any), interest and other moneys payable in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat INFINIS FINANCE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0