EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED

EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05257695
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Feb. 2015

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 09. März 2015

    12 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Aug. 2014

    12 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Feb. 2014

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    9 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Aug. 2013

    11 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Farringdon Place 20 Farringdon Road London EC1M 4AP* am 22. Aug. 2013

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Feb. 2013

    12 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Okt. 2012

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    65 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B

    8 Seiten2.16B

    legacy

    1 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 18 Buckingham Gate London SW1E 6LB* am 18. Apr. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Okt. 2011

    Kapitalaufstellung am 21. Okt. 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Ernennung von Mr Nigel Howard Pope als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Nicola Louise Lenthall als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Stephen Corner als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LENTHALL, Nicola Louise
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Sekretär
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    158015780001
    POPE, Nigel Howard
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish29583660002
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish109810150001
    CORNER, Stephen Donald
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    Sekretär
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    British85743480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TAYLOR, Russell John
    Church Road
    NE9 5XE Gateshead
    123
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    Church Road
    NE9 5XE Gateshead
    123
    Tyne And Wear
    EnglandBritish79902420003

    Hat EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Juli 2010
    Geliefert am 06. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Charge over construction contract
    Erstellt am 31. Aug. 2006
    Geliefert am 07. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in the construction contract dated 20 march 2006 all sums payable under the building contract and all rights arising out any breach of default under any terms obligations undertakings or conditions of the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 04. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as cherry blossom way washington tyne & wear t/n TY201735,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 217. Apr. 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 217. Apr. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 04. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 23. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 23. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the south of washington road washington t/no TY201735 all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat EASTER DEVELOPMENTS (CHERRY BLOSSOM) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Apr. 2012Beginn der Verwaltung
    09. März 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Douglas Ernle Money
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    Praktiker
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    James Henry Stewart-Koster
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    Praktiker
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Douglas Ernle Money
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    Receiver Manager
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    James Henry Stewart-Koster
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    Receiver Manager
    Farringdon Place 20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0