STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05263204 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED?
- Aktivitäten von Reiseveranstaltern (79120) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Glendale House Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
S8 (UK) LIMITED | 03. Okt. 2006 | 03. Okt. 2006 |
HWT (EUROPE) LIMITED | 19. Okt. 2004 | 19. Okt. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Asif Hamza Parkar am 27. Okt. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Stephen John Allen als Direktor am 29. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Charles Richard Andrew als Geschäftsführer am 30. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ryan James Cooke als Sekretär am 29. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Dnata Travel Holdings Uk Limited as a person with significant control on 31. Mai 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 19 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew James Washington als Geschäftsführer am 21. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 43 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Ian Botterill als Geschäftsführer am 26. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLEN, Stephen John | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | United Arab Emirates | British | Director | 268852380001 | ||||
PARKAR, Asif Hamza | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | United Arab Emirates | British | Director | 192786110001 | ||||
BHOGAL, Joginder Singh | Sekretär | The Beeches 78a Hatch Lane Old Basing RG24 7EF Basingstoke Hampshire | British | Chartered Accountant | 65117380002 | |||||
CAMPBELL, Grant | Sekretär | 93 Fremantle Drive WS12 2GY Wimblebury Staffordshire | Australian | Company Director | 103796030002 | |||||
COOKE, Ryan James | Sekretär | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | 228312230001 | |||||||
MONTGOMERY, Fiona Jane | Sekretär | 59 Keats Avenue RH1 1AF Redhill Surrey | Australian | Finance Director | 127487450001 | |||||
PENNY, Jens Leslie | Sekret är | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | British | Director | 95188170002 | |||||
TAYLOR, Gregory John | Sekretär | 4 Watson Close Fradley WS13 8UA Lichfield Staffordshire | British | 118686530001 | ||||||
7SIDE SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 1st Floor 14-18 City Road CF24 3DL Cardiff South Glamorgan | 39827800003 | |||||||
DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||
HEATONS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 5th Floor Free Trade Exchange 37 Peter Street M2 5GB Manchester Greater Manchester | 87457570002 | |||||||
ANDREW, Iain Charles Richard | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | United Arab Emirates | British | Divisional Senior Vice President | 165878720001 | ||||
BECK, Raymond Paul | Geschäftsführer | 15 Kitswell Way WD7 7HN Radlett Hertfordshire | British | Director | 30070330001 | |||||
BOTTERILL, Andrew Ian | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | England | British | Director | 77385660007 | ||||
DODDS, Timothy Alan Charles | Geschäftsführer | 10 Blenheim Close ST180WB Stafford Staffordshire | Australian | Company Director | 101572890002 | |||||
GAINES, Elizabeth Anne | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | Australia | Australian | Director | 139667300008 | ||||
KRECKLENBERG, Rolf Julian | Geschäftsführer | 1 Wallangra Road 2030 Dover Heights Nsw 2030 Australia | Australia | Australian | Ceo Mfs Tourism | 122139770001 | ||||
LAURIE, Andrew Robert | Geschäftsführer | White House Cliffords Wood Swynnerton ST15 0QS Stone Staffordshire | Australian | Director | 117639030001 | |||||
MAYO, Barry Leonard Anthony | Geschäftsführer | 82 Lagoon Road Narrabeen New South Wales Australia | Australian | Company Director | 101572760001 | |||||
PENNY, Jens Leslie | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | England | British | Director | 95188170003 | ||||
POLLARD, Ailsa Elizabeth | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | United Arab Emirates | British | Management | 271097360001 | ||||
SHENG YANG, Sunny Li | Geschäftsführer | 10 Churchill Road Killara Nsw 2071 Australia | Australian | Cfo Mfs Tourism | 122139930001 | |||||
STANLEY, Keith Bancroft Anthony | Geschäftsführer | 703 38 Refinery Drive FOREIGN Pyrmont Sydney Nsw 2009 Australia | Australian | Ceo Stella Travel | 122570550001 | |||||
WASHINGTON, Andrew James | Geschäftsführer | Glendale Business Park Glendale Avenue Sandycroft CH5 2DL Deeside Glendale House | England | British | Director | 101929630001 | ||||
7SIDE NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 14-18 City Road CF24 3DL Cardiff South Glamorgan | 78183280003 | |||||||
DLA NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146610001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnata Travel Holdings Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 14. Okt. 2014 Geliefert am 27. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security agreement | Erstellt am 31. Juli 2009 Geliefert am 13. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the all assets present and future, including property goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 19. Dez. 2008 Geliefert am 23. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 02. Sept. 2008 Geliefert am 05. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 22567716 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 31. Okt. 2007 Geliefert am 02. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £3,499,866.03 credited to account designation 22567716 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derived in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security agreement | Erstellt am 06. Sept. 2007 Geliefert am 24. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security agreement | Erstellt am 06. Sept. 2007 Geliefert am 24. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security agreement | Erstellt am 06. Sept. 2007 Geliefert am 24. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 30. Juli 2007 Geliefert am 17. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Mai 2007 Geliefert am 14. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or an obligor to a finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat STELLA TRAVEL SERVICES (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0