INTRUM UK FUNDING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | INTRUM UK FUNDING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05265651 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INTRUM UK FUNDING LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich INTRUM UK FUNDING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Omnibus Building Lesbourne Road RH2 7JP Reigate Surrey |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INTRUM UK FUNDING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
1ST CREDIT (FUNDING) LIMITED | 28. Okt. 2004 | 28. Okt. 2004 |
DE FACTO 1161 LIMITED | 20. Okt. 2004 | 20. Okt. 2004 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTRUM UK FUNDING LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INTRUM UK FUNDING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Reza Atighi als Geschäftsführer am 28. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Anette Willumsen als Direktor am 30. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marc Knothe als Geschäftsführer am 30. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bruce Mclaren als Sekretär am 04. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 052656510010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 052656510011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 052656510011, erstellt am 01. Okt. 2019 | 19 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 49 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Collector Services Ltd as a person with significant control on 01. März 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Leith Johnston Robertson als Geschäftsführer am 19. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bruce Mclaren als Geschäftsführer am 19. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INTRUM UK FUNDING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTT, Edward Brian | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | United Kingdom | British | Director | 61734100004 | ||||
WILLUMSEN, Anette | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | Norway | Norwegian | Managing Director | 274868530001 | ||||
DIGHTON, Simon Gerald | Sekretär | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | British | 78151560001 | ||||||
MCLAREN, Bruce | Sekretär | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | 206334130001 | |||||||
NATHOO, Najib | Sekretär | 9 Victoria Court Royal Earlswood Park RH1 6TE Redhill Surrey | British | Director | 89213230002 | |||||
STOREY, Richard Lionel | Sekretär | Broom Cottage Sunset Lane RH20 2NY West Chiltington West Sussex | British | Chartered Acct | 105579670001 | |||||
TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 38590450001 | |||||||
ATIGHI, Reza | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | England | Dutch | Investment Director | 243503920001 | ||||
BURGESS, Andrew | Geschäftsführer | Crann Dara East Flexford Lane Wanborough GU3 2JP Guildford Surrey | British | Investment Banker | 109616920001 | |||||
CLEARY, Michael John | Geschäftsführer | Redriff Farm Birchwood Lane CR3 5DQ Chaldon Surrey | United Kingdom | British | Director | 40688830004 | ||||
CULLEY, Kenneth | Geschäftsführer | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London | United Kingdom | British | Chairman | 72217420002 | ||||
DAVISON, John Michael | Geschäftsführer | South Hill Park NW3 2SP Hampstead 105 London | England | British | Investment Banker | 158870560001 | ||||
DIGHTON, Simon Gerald | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | United Kingdom | British | Director | 78151560001 | ||||
FOX, Patrick Adam Charles | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1FB London 95 | England | British | Venture Capital | 116703610001 | ||||
GREEN, Stephen | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1FB London 95 | England | British | Partner | 62499540004 | ||||
HOLLAND, Charles James Trevenen | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | England | British | Director | 64452440005 | ||||
KNOTHE, Marc | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | Austria | German | Managing Director | 243503770001 | ||||
MCLAREN, Bruce | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | England | British | Director | 182989060001 | ||||
MOTA DUARTE, Luis Filipe | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1FB London 95 | Uk | Portuguese | Fund Manager | 152510830001 | ||||
NATHOO, Najib Abdul | Geschäftsführer | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London | United Kingdom | British | Director | 89213230004 | ||||
REYNOLDS, Kevin Paul | Geschäftsführer | Warwick Street W1B 5AL London 30 | England | British | Director | 101625190003 | ||||
ROBERTSON, Iain Leith Johnston | Geschäftsführer | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building Surrey | United Kingdom | British | Chairman | 146368930001 | ||||
STOREY, Richard Lionel | Geschäftsführer | Broom Cottage Sunset Lane RH20 2NY West Chiltington West Sussex | British | Chartered Accountant | 105579670001 | |||||
YOUNG, Simon | Geschäftsführer | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London | England | British | Chief Risk Officer | 190930920001 | ||||
TRAVERS SMITH LIMITED | Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 47670880001 | |||||||
TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 38590450001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INTRUM UK FUNDING LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intrum Uk Group Limited | 14. Feb. 2017 | Lesbourne Road RH2 7JP Reigate The Omnibus Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Bridgepoint Capital (Gp) Limited | 06. Apr. 2016 | Wigmore Street W1U 1FB London 95 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Bridgepoint Advisers Limited | 06. Apr. 2016 | Wigmore Street W1U 1FB London 95 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat INTRUM UK FUNDING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Okt. 2019 Geliefert am 07. Okt. 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. Sept. 2017 Geliefert am 29. Sept. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over shares | Erstellt am 03. Dez. 2010 Geliefert am 14. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest from time to time in the securities and to the related investment rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over shares | Erstellt am 03. Dez. 2010 Geliefert am 10. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the chargor's right title and interest from time to time in the securities and all related investment rights. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 22. Feb. 2008 Geliefert am 05. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2008 Geliefert am 13. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee and / or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Feb. 2008 Geliefert am 13. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to any security trustee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 27. Feb. 2007 Geliefert am 08. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Dez. 2005 Geliefert am 11. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Okt. 2004 Geliefert am 17. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Okt. 2004 Geliefert am 09. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to the security trustee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future right,title and interest of the company in the property all other property and all interests in property,all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0