SPIRIT MANAGED INNS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPIRIT MANAGED INNS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05266815 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPIRIT MANAGED INNS LIMITED?
- Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe
- Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe
Wo befindet sich SPIRIT MANAGED INNS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Westgate Brewery IP33 1QT Bury St Edmunds Suffolk United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPIRIT MANAGED INNS LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SPIRIT MANAGED INNS LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 29. Sept. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 13. Okt. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 29. Sept. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPIRIT MANAGED INNS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Dez. 2024 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 10 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Nov. 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Jan. 2023 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Nicholas D'cruz als Direktor am 31. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Robert Lee als Geschäftsführer am 31. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Jan. 2022 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Robert Lee als Direktor am 15. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Smothers als Geschäftsführer am 15. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 03. Jan. 2021 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2021 bis 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Apr. 2020 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Apr. 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPIRIT MANAGED INNS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Sekretär | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | 207524380001 | |||||||
| D'CRUZ, Simon Nicholas | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242723610001 | |||||
| JONES, Henry | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592400001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Sekretär | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445830001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021690001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Sekretär | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| JACKSON, John Robert | Geschäftsführer | Ivy Lodge Main Road Pentrich DE5 3RE Ripley Derbyshire | England | British | 97361680001 | |||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Geschäftsführer | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| LEE, Matthew Robert | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | England | British | 286667680001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PEEL, Stephen Mark | Geschäftsführer | 4 Neville Street SW7 3AR London | British | 54712990002 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| RIKLIN, Cornel Carl | Geschäftsführer | 103 Barrow Gate Road Chiswick W4 4QS London | England | Swiss | 78412270001 | |||||
| SMITH, Benedict James | Geschäftsführer | Flat 9 62 Eccleston Square SW1V 1PH London | United Kingdom | British | 75231110001 | |||||
| SMOTHERS, Richard | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242658700001 | |||||
| STONE, Stephen John | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131652460001 | |||||
| THORLEY, Giles Alexander | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 81928120002 | |||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Geschäftsführer | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | England | British | 135181230001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SPIRIT MANAGED INNS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Parent Limited | 06. Apr. 2016 | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0