C M SHEFFIELD LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | C M SHEFFIELD LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05282146 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von C M SHEFFIELD LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich C M SHEFFIELD LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Fourth Floor 110 Wigmore Street W1U 3RW London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von C M SHEFFIELD LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für C M SHEFFIELD LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Okt. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Ross Hillier Mccaskill als Direktor am 17. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Andrew Batchelor als Geschäftsführer am 17. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Mark Vaughan als Geschäftsführer am 29. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Andrew Batchelor am 18. Dez. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von C M SHEFFIELD LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARE, Robert Thomas Ernest | Sekretär | Woodley Lodge Duffield Road RG5 4RL Woodley Berkshire | British | 4779170003 | ||||||
| MCCASKILL, Ross Hillier | Geschäftsführer | 110 Wigmore Street W1U 3RW London Fourth Floor | United Kingdom | British | 196173140001 | |||||
| SEBIRE, Andrew Foot | Geschäftsführer | Lower Hurst Farm Hartington SK17 0HJ Buxton Derbyshire | England | British | 12454040001 | |||||
| SEBIRE, Thomas Berisford | Geschäftsführer | 48 Moreton Street SW1V 2PB London | England | British | 80202980002 | |||||
| BATCHELOR, Peter Andrew | Sekretär | Flat 269 North County Hall 1c Belvedere Road SE1 7GF London | British | 68594020002 | ||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Sekretär | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham West Midlands | 39944230001 | |||||||
| BATCHELOR, Peter Andrew | Geschäftsführer | Parc Owles Carbis Bay TR26 2RE St. Ives An Mordros Cornwall England | England | British | 68594020004 | |||||
| VAUGHAN, Steven Mark | Geschäftsführer | Ewshot Hurst Church Lane Ewshot GU10 5BD Farnham Surrey | England | British | 98406850001 | |||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Geschäftsführer | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham West Midlands | 39944220001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei C M SHEFFIELD LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreton Street Limited | 06. Apr. 2016 | Moreton Street SW1V 2PB London 48 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat C M SHEFFIELD LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 27. Mai 2005 Geliefert am 03. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land and buildings at sheffield business park t/no SYK451087 and SYK384600. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Jan. 2005 Geliefert am 03. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 2005 Geliefert am 02. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units P1, P2, P3 and P4 sheffield business park, europa link, sheffield t/no SYK451087. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 2005 Geliefert am 02. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units g, h, j, k, l, m, n, p and q sheffield business park, europa link, sheffield t/no's SYK439152 and SYK439148. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 2005 Geliefert am 02. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit s, sheffield business park, europa link, sheffield t/no's SYK451087 and SYK438646. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal assignment of rent | Erstellt am 21. Jan. 2005 Geliefert am 02. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights, title, interest and benefit in and to the rent. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit with the bank | Erstellt am 21. Jan. 2005 Geliefert am 02. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit being all deposits now and in the future credited to account designation no 11037758 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0