ASHBOURNE BOSS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASHBOURNE BOSS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05282592 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASHBOURNE BOSS LIMITED?
- Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich ASHBOURNE BOSS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASHBOURNE BOSS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASHBOURNE BOSS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 31. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor am 31. Aug. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASHBOURNE BOSS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVETT, David Charles | Geschäftsführer | The Grange SW19 4PS London 17 England England | United Kingdom | British | 34419700002 | |||||
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| KIME, Sean Thomas | Sekretär | Flat 1, 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 96974070001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304860001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BAILEY, Anne | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 118289800001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| COUSINS, Carol | Geschäftsführer | Crumlin Road Ballinderry Upper BT28 2JX Lisburn 26 County Antrim | Northern Ireland | British | 249170210001 | |||||
| FEARN, Lynn | Geschäftsführer | Elmwood Drive DE55 7QJ Alfreton 24 Derbyshire | United Kingdom | British | 130867640001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Geschäftsführer | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Geschäftsführer | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HAINES, Ellen | Geschäftsführer | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | British | 89071020003 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Geschäftsführer | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MACINTOSH, Michael | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 137864880001 | |||||
| MALHAM, Janette | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 91088900004 | |||||
| MCKEEVER, Pauline Ann | Geschäftsführer | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | 91521130001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| POYNTON, Ellen | Geschäftsführer | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | United Kingdom | British | 89071020004 | |||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| STOREY, John | Geschäftsführer | 93 Dacre Park Blackheath SE13 5BX London | British | 60123860002 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat ASHBOURNE BOSS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 18. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property known as chester housecare centre 8/10 third avenue sherwood R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 18. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property known as nightingale court 11 to 14 comberton road kidderminste. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 18. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property known as burgh hall hall lane skegness lincolnshire t/n LL24913. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 18. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property known as stafford HALL138-140 thundersley park road south benf. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 18. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property known as stafford court care centre venables close canvey islan. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 18. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property known as st paul's nursing home high street waddington lincoln,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 2005 Geliefert am 18. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property known as sampford house 27 shurnold melsham wiltshire t/n WT234. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 6 july 2005 and | Erstellt am 28. Juni 2005 Geliefert am 09. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Lease between cannon capital boss limited and ashbourne boss limited dated 28 june 2005 k/a muirton house nursing home essendy road blairgowrie t/no PTH25285. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 10. Mai 2005 Geliefert am 20. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the l/h estates being, l/h property k/a great horkesley manor, nayland road, great horkesley, colchester. T/no EX445283 including all fixtures, all proceeds of sale, all proceeds of any insurance and the benefit of all covenants, future rights, other rights under operating lease, contracts, book debts, cash receipts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 10. Mai 2005 Geliefert am 20. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all rights relating to the property being, l/h property k/a nayland house, bear street, nayland, colchester. T/no SK190856 and SK200198 including all fixtures, all proceeds of sale, all proceeds of any insurance, the benefit of all covenants, future rights, other rights under operating lease, contracts, book debts, cash receipts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 23 february 2005 and | Erstellt am 11. Feb. 2005 Geliefert am 04. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Lease of the subjects known as and forming broomfield nursing home broomfield road glasgow t/n GLA122661. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 11. Feb. 2005 Geliefert am 25. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property, assets and undertaking of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 07. Dez. 2004 Geliefert am 22. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other group company (or any one or more of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Dunnaney, 12 glebe road, carnmoney, newtownabbey, county antrim; glebe, 2 glebe road, carnmoney, newtownabbey, county antrim; kingsland 252 seacliff road, bangor county down. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 25. Nov. 2004 Geliefert am 03. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Legal charged property being melmount manor, 1 orchard road, strabane; culmore manor nursing home, 39 culmore road, londonderry; greenhaw lodge, 42 racecourse road, londonderry; templemoyle private nursing home, 41A whitehall road, eglinton, county londonderry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ASHBOURNE BOSS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0