LIQUICO KHIL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLIQUICO KHIL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05293889
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LIQUICO KHIL LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich LIQUICO KHIL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o DELOITTE LLP
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LIQUICO KHIL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KINGFIELD HEATH INVESTMENTS LIMITED30. Nov. 200430. Nov. 2004
    INTERCEDE 1979 LIMITED23. Nov. 200423. Nov. 2004

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LIQUICO KHIL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für LIQUICO KHIL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom K House Sheffield Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU zum C/O Deloitte Llp 1 City Square Leeds West Yorkshire LS1 2AL am 21. Aug. 2015

    2 SeitenAD01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf K House Sheffield Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU geändert

    2 SeitenAD02

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Aug. 2015

    LRESSP

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 30. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed kingfield heath investments LIMITED\certificate issued on 28/04/15
    3 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 27. Apr. 2015

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 11. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 9,000,001
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    8 SeitenAA

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 06. Juni 2007

    • Kapital: GBP 9,000,001
    3 SeitenSH01

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 9,000,001
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    14 SeitenMG01

    legacy

    12 SeitenMG01

    Wer sind die Geschäftsführer von LIQUICO KHIL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALDREY, Robert Rolph
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    South Yorkshire
    EnglandBritish78328360005
    GALE, Andrew Peter
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    South Yorkshire
    EnglandBritish155681500001
    FULLER, Colin Eric
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    Sekretär
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    British59600860003
    JOHNSTON, Wilfred Mark
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    British107055750001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    BARCLAY, Alan
    K House
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Europa Link
    Sheffield
    Geschäftsführer
    K House
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Europa Link
    Sheffield
    EnglandBritish52823240003
    BARCLAY, Alan
    17a Bridle Road
    Bramcote
    NG9 3DH Nottingham
    Geschäftsführer
    17a Bridle Road
    Bramcote
    NG9 3DH Nottingham
    EnglandBritish52823240003
    FULLER, Colin Eric
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    EnglandBritish59600860003
    JOHNSTON, Wilfred Mark
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish107055750001
    MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald
    Brook Farm
    Drinkstone Road, Beyton
    IP30 9AQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Brook Farm
    Drinkstone Road, Beyton
    IP30 9AQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish185639660001
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900027570001

    Hat LIQUICO KHIL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture governed by the law of northern ireland
    Erstellt am 26. Sept. 2012
    Geliefert am 05. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each security obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2012
    Geliefert am 05. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each security obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2012
    Geliefert am 05. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each security obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 03. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 03. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Party
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 03. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Party
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 28. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 28. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 25. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from that chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 25. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from that chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee Itself and the Other Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge any money standing to the credit of each designated account of that chargor and the debts by way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 23. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Group debenture
    Erstellt am 09. Dez. 2004
    Geliefert am 16. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the security provider to any regulated creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LIQUICO KHIL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Aug. 2015Beginn der Liquidation
    09. Dez. 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0