GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05298873 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unicorn House Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough East Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Cowan als Sekretär am 30. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Sherriff als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Matthew Cowan als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR United Kingdom am 28. Juni 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unicorn House, Broad Lane Gilberdyke Brough East Yorkshire HU15 2TS am 27. Juni 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Bradney als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Christopher Harris als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Terence Jackson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von James Bradney als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher John Huckle als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Sherriff als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Clarke als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Terence William Jackson am 11. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Stephen Clarke am 11. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, David Christopher | Geschäftsführer | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | England | British | 76088090001 | |||||
| HUCKLE, Christopher John | Geschäftsführer | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141831160001 | |||||
| BALL, Martin John | Sekretär | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | British | 63261140001 | ||||||
| CLARKE, Stephen | Sekretär | Unicorn House, Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough East Yorkshire | British | 122285190001 | ||||||
| COWAN, Matthew | Sekretär | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | 161230390001 | |||||||
| SHERRIFF, Ian | Sekretär | Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough Unicorn House East Yorkshire United Kingdom | 149407920001 | |||||||
| ATKINSON, Stewart Martin | Geschäftsführer | Springwell 32 Bondend Road Upton St Leonards GL4 8DY Gloucester Gloucestershire | England | British | 100469640001 | |||||
| BALL, Martin John | Geschäftsführer | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | United Kingdom | British | 63261140001 | |||||
| BALL, Martin John | Geschäftsführer | Sandwood House Ashfield LE15 6QB Oakham Rutland | United Kingdom | British | 63261140001 | |||||
| BRADNEY, James | Geschäftsführer | Unicorn House, Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough East Yorkshire | United Kingdom | British | 161101450001 | |||||
| CLARK, William Angus | Geschäftsführer | Folds Head Close Folds Head, Calver S32 3XJ Hope Valley Derbyshire | British | 80223540001 | ||||||
| JACKSON, Terence William | Geschäftsführer | Unicorn House, Broad Lane Gilberdyke HU15 2TS Brough East Yorkshire | Uk | British | 132410210001 |
Hat GATEWAY BATHROOM PODS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2009 Geliefert am 20. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 16. Nov. 2009 Geliefert am 20. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 06. Nov. 2009 Geliefert am 18. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Okt. 2008 Geliefert am 18. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 18. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Jan. 2005 Geliefert am 03. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0