EVER 2532 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EVER 2532 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05304980 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EVER 2532 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich EVER 2532 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | First Floor, 107 Station Street DE14 1SZ Burton-On-Trent Staffordshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVER 2532 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EVER 2532 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Change of details for Inspired Gaming (Holdings) Limited as a person with significant control on 08. Juni 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 the Maltings Wetmore Road Burton on Trent Staffordshire DE14 1SE zum First Floor, 107 Station Street Burton-on-Trent Staffordshire DE14 1SZ am 08. Juni 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2019 bis 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Feb. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Holmes als Geschäftsführer am 22. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Stewart Frank Bradley Baker als Direktor am 21. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Sept. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Sept. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James William O'halleran als Geschäftsführer am 02. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EVER 2532 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMON, Carys | Sekretär | Station Street DE14 1SZ Burton-On-Trent First Floor, 107 Staffordshire England | 196165170001 | |||||||
| BAKER, Stewart Frank Bradley | Geschäftsführer | Station Street DE14 1SZ Burton-On-Trent First Floor, 107 Staffordshire England | United Kingdom | British | 230753770001 | |||||
| ALBION, Susan | Sekretär | 7 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | 80142740001 | ||||||
| HOLMES, Steven John | Sekretär | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | British | 80455940002 | ||||||
| OLDHAM, Annette | Sekretär | Edwards Farm Road Fradley WS13 8NR Lichfield 29 Staffordshire | British | 135120610001 | ||||||
| PAGE, David | Sekretär | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | British | 31059170002 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||
| ALVAREZ, Luke Lyon | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 63436630003 | |||||
| ALVAREZ, Luke Lyon | Geschäftsführer | Flat 21 The Pryors East Heath Road NW3 1BS London | United Kingdom | British | 63436630003 | |||||
| CROWLEY, Norman Vincent | Geschäftsführer | Deerfield House Ballybrew Enniskerry IRISH Dublin County Wicklow Eire | Ireland | Irish | 112556660004 | |||||
| CROWLEY, Norman Vincent | Geschäftsführer | Deerfield House Ballybrew Enniskerry IRISH Dublin County Wicklow Eire | Ireland | Irish | 112556660004 | |||||
| HOLMES, Steven John | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 195545010001 | |||||
| HOYLE, Russell Blackburn | Geschäftsführer | 5 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | 52822380002 | |||||
| O'HALLERAN, James William | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | 103876820003 | |||||
| PAGE, David | Geschäftsführer | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | England | British | 31059170002 | |||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EVER 2532 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspired Gaming (Holdings) Limited | 06. Apr. 2016 | 107, Station Street DE14 1SZ Burton-On-Trent First Floor Staffordshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EVER 2532 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An accession deed | Erstellt am 02. Juni 2006 Geliefert am 12. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2005 Geliefert am 11. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 2005 Geliefert am 11. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0