RIPSHORE PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RIPSHORE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05307707 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ashley House Ashley Road KT18 5AZ Epsom Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. März 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Gaffney als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Edward Lewis als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Neil Fitzsimmons als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Gaffney am 29. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Lavelle als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Johnson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Joanne Elizabeth Massey als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Robin Simon Johnson am 24. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Gaffney am 13. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dominic Joseph Lavelle am 06. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 29. Nov. 2006
| 2 Seiten | SH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2008 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RIPSHORE PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Sekretär | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147807860001 | |||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| BROWN, Carole Elizabeth | Sekretär | The Old Bakehouse School Lane Loughton MK5 8AT Milton Keynes Buckinghamshire | British | 98235420001 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Sekretär | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| FORBES SECRETARIES LIMITED | Sekretär | New City House 71 Rivington Street EC2A 3AY London | 67773790001 | |||||||
| BROWN, Carole | Geschäftsführer | 2 Fox Hedge Way Sharnbrook MK44 1JR Bedford Bedfordshire | British | 114018470001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Geschäftsführer | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Geschäftsführer | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| GAFFNEY, David | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Geschäftsführer | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| GARNER, Tony Christopher | Geschäftsführer | 7 Grange Road MK45 4RE Barton Le Clay Bedfordshire | England | British | 79630360001 | |||||
| JAMES, Peter | Geschäftsführer | 9 High View Road South Woodford E18 2HN London | England | British | 86901660001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MOTION, Michelle Hunter | Geschäftsführer | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | United Kingdom | British | 78545300002 | |||||
| MURPHY, John William | Geschäftsführer | 19 Esplanade Gardens SS0 8JP Westcliff On Sea Essex | England | British | 202959810002 | |||||
| PEDLEY, Mark Jonathan | Geschäftsführer | Morningdale 421 Weedon Road NN5 4EX Northampton Northamptonshire | British | 112119110001 | ||||||
| FORBES NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | New City House 71 Rivington Street EC2A 3AY London | 67773780001 |
Hat RIPSHORE PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2008 Geliefert am 09. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a hammarsfield standon near ware. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. März 2005 Geliefert am 31. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0