VALEFROST LIMITED
Überblick
Unternehmensname | VALEFROST LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05312146 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VALEFROST LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich VALEFROST LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Elsley House 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VALEFROST LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VALEFROST LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für VALEFROST LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Dez. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Nimmo Cameron als Geschäftsführer am 03. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg als Direktor am 06. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Michael Jowsey als Direktor am 06. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Michael Forde als Direktor am 06. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gavin Nimmo Cameron am 13. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gavin Nimmo Cameron am 08. Jan. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Gavin Nimmo Cameron als Direktor am 26. Jan. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Anthony Mcquade als Geschäftsführer am 26. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ashby Street 1 Bridge Street Staines TW18 4TP am 20. Dez. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VALEFROST LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORDE, David Michael | Geschäftsführer | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Ireland | Irish | Managing Director | 178655370001 | ||||
JOWSEY, Christopher Michael | Geschäftsführer | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | United Kingdom | British | Trading Director | 152505410002 | ||||
MOORE, Christopher John | Geschäftsführer | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 136853310001 | ||||
VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus | Geschäftsführer | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Scotland | Dutch | Finance Director | 167853370002 | ||||
INGHAM, Michael Harry Peter | Sekretär | 3 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | Chartered Accountant | 2739650001 | |||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 69 Southampton Row WC1B 4ET London Marquess Court | 900027310001 | |||||||
BROWN, Aaron Maxwell | Geschäftsführer | Elsworthy Terrace NW3 3DR London 5 | United Kingdom | British | Business Consultant | 98928830002 | ||||
CAMERON, Gavin Nimmo | Geschäftsführer | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | United Kingdom | British | Head Of Snpc Commercial Finance | 87163500002 | ||||
GRUNNEL, Mark | Geschäftsführer | 3 Montolieu Gardens SW15 6PB London | United Kingdom | British | Director | 107643340002 | ||||
MACINTYRE, Donald Calum | Geschäftsführer | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 2-4 | Scotland | British | Chartered Accountant | 140968790001 | ||||
MCQUADE, Stephen Anthony | Geschäftsführer | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley House United Kingdom | Scotland | British | Head Of Strategic Projects And Joint Ventures | 161091550001 | ||||
SANTRY, Kevin James Albert | Geschäftsführer | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 2-4 | Scotland | British,Irish | Solicitor | 151364260001 | ||||
SMALLEY, Timothy John | Geschäftsführer | Chivers Road CM15 0LG Stondon Massey Stondon Place Essex | United Kingdom | British | Company Director | 102593650002 | ||||
TCHENGUIZ, Robert | Geschäftsführer | Royal College Of Organists 26 Kensington Gore SW7 2ET London | England | British | Director | 74322720004 | ||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 69 Southampton Row WC1B 4ET London Marquess Court | 900027300001 |
Hat VALEFROST LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A standard security which was presented for registration in scotland on the 04/08/2006 and | Erstellt am 27. Juli 2006 Geliefert am 18. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All stars international 326-328 brook street broughty ferry dundee t/no ANG19917, all stars international 17-19 swan street brechin t/no ANG25146 and all stars internationas 85-87 commercial street dundee for details of further properties charged please refer to form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security agreement | Erstellt am 06. Juni 2006 Geliefert am 22. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Bedroom 127 micklegate york t/no nyk 1401971, black swan 12 new road spalding lincs t/no LL117200 and broadways 15 the broadway newbury berks t/no BK325120 for details of further properties charged please refer to form 395 all buildings fixtures fittings and fixed plat and machinery the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security agreement | Erstellt am 22. Mai 2006 Geliefert am 02. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The townhouse 21-23 queen's road southend-on-sea t/no EX154112 and the barcode (formerly k/a the caledonian) 17 bothchergate carlisle t/no CU166351. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignation of rents | Erstellt am 24. Jan. 2006 Geliefert am 08. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargors whole right title and interest in and to the rental income from the properties. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on the 30 january 2006 and | Erstellt am 16. Jan. 2006 Geliefert am 08. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the licensed premises k/a burnfoot roadhouse burnfoot hawick t/no ROX7282,all and whole the licensed premises k/a the horse & hound bonchester bridge by hawick t/no ROX7281,all and whole the licensed premises and k/a stampers 2/6 north bridge street hawick t/no ROX7280 (for details of further properties charged please refer to form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security agreement | Erstellt am 16. Jan. 2006 Geliefert am 25. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or ot become due from each chargor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Albert inn 40 mount street northwood hanley stoke on trent t/no SF311537, bay wickentree lane failsworth t/no LA305120 and cock horse main street peasemarsh t/no ESX186313 for details of further properties charged please refer to form 395 all buildings fixtures fittings fixed plant and machinery the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 20. Dez. 2005 Geliefert am 23. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or ot become due from each chargor to any creditor on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0