MW PROPERTIES NO 16 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MW PROPERTIES NO 16 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05323472 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MW PROPERTIES NO 16 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MW PROPERTIES NO 16 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Mw House 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Leicester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MW PROPERTIES NO 16 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 05. Apr. 2015 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MW PROPERTIES NO 16 LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MW PROPERTIES NO 16 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Louisa Jane Poole am 27. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Miss Louisa Jane Poole als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Mw House 1 Penman Way Grove Park, Enderby Leicester LE19 1SY United Kingdom* am 17. Jan. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Benjamin Lopian am 04. Jan. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Ian Thomas Mattioli am 04. Jan. 2013 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Mw House, 1 Penman Way Grove Park Enderby Leicester LE19 1SY* am 20. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Antony Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Antony Smityh am 24. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Antony Smityh als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MW PROPERTIES NO 16 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTIOLI, Ian Thomas | Sekretär | 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Mw House Leicester United Kingdom | British | 163154520001 | ||||||
LOPIAN, Michael Benjamin | Geschäftsführer | 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Mw House Leicester United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 13307000001 | ||||
POOLE, Louisa Jane | Geschäftsführer | 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Mw House Leicester | United Kingdom | British | Director | 140192180003 | ||||
SMITH, Mark Antony | Geschäftsführer | 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Mw House Leicester United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 154932780003 | ||||
FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900015000001 | |||||||
SMITH, Mark Antony | Geschäftsführer | 1 Penman Way Grove Park LE19 1SY Enderby Mw House, Leicester | United Kingdom | British | Director | 154932780003 | ||||
FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester | 900014990001 |
Hat MW PROPERTIES NO 16 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 10. Juni 2005 Geliefert am 21. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/a phase 4 grove park, narborough road, south, enderby, leicestershire and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleaeses tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or otherdealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge all the other property assets and rights of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Juni 2005 Geliefert am 21. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/a phase 4 grove park, narborough road, south, enderby, leicestershire and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleaeses tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or otherdealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge all the other property assets and rights of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0