LAMB TECHNICON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLAMB TECHNICON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05334478
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LAMB TECHNICON LIMITED?

    • (2852) /

    Wo befindet sich LAMB TECHNICON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP
    St Philips Point
    Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LAMB TECHNICON LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INTERCEDE 2012 LIMITED17. Jan. 200517. Jan. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAMB TECHNICON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für LAMB TECHNICON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    19 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Okt. 2011

    13 Seiten4.68

    Gerichtsbeschluss, der dem freiwilligen Liquidator die Erlaubnis zum Rücktritt erteilt

    1 Seiten4.35

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    6 SeitenLIQ MISC OC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Fourth Floor Fort Dunlop Fort Parkway Birmingham West Midlands B24 9FD am 21. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 04. Okt. 2010

    LRESSP

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2009 bis 30. Juni 2010

    3 SeitenAA01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Feb. 2010

    Kapitalaufstellung am 03. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Boyd am 03. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Gerhard Hagenau am 03. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    15 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von LAMB TECHNICON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOYD, John
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    Sekretär
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    BritishDirector135386290001
    BOYD, John
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Digby Road
    B73 6HG Sutton Coldfield
    7
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director135386290001
    HAGENAU, Gerhard
    Wolfsgrube 5
    Chieming
    83339
    Germany
    Geschäftsführer
    Wolfsgrube 5
    Chieming
    83339
    Germany
    GermanyGermanChief Financial Officer139197540001
    THEISEN, Bernard Joseph
    1404 Kensington
    Grosse Pointe Park
    Michigan 48230
    Usa
    Sekretär
    1404 Kensington
    Grosse Pointe Park
    Michigan 48230
    Usa
    British104568400001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    BENJAMIN, James Cover
    10213 Discovery Terrace
    Bradenton
    Florida 34212
    Usa
    Geschäftsführer
    10213 Discovery Terrace
    Bradenton
    Florida 34212
    Usa
    AmericanExecutive Vp104568880001
    MANTLE, Neil
    19c Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    19c Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    BritishGeneral Manager124095260001
    VERESCHAGIN, Gregory Lyle
    7 Samuel Dann Way
    Pound Ridge
    New York
    10576
    Usa
    Geschäftsführer
    7 Samuel Dann Way
    Pound Ridge
    New York
    10576
    Usa
    AmericanExecutive104568230001
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900027570001

    Hat LAMB TECHNICON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 02. Juli 2006
    Geliefert am 12. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re lamb technicon limited business premium account ac/no 60155195. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Consolidated amended and restated security agreement
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A security interest in and lien upon all of its right, title and interest in, to and under all personal property and other assets, whether then owned by or owing to, or thereafter acquired by or arising in favour of the grantor and whether owned or consigned by or to, or leased from or to, the grantor, and regardless of where located (the collateral). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Consolidated amended and restated patent and trademark security agreement
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A continuing first priority security interest in and lien (as applicable) upon all of its right, title and interest in, to and under all of its owned and thereafter acquired or arising and filed patnets and patent applications and all of its patent licenses. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Consolidated amended and restated copyright security agreement
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to agents or any revolving credit lender or any tranche b lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A continuing first priority security interest in and lien (as applicable) upon all of its right, title and interest in, to and under all of its then owned and thereafter acquired or arising and registered copyrights, all copyright licences to which it is a party and all license fees and royalties arising. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc, as Collateral Agent for the Agents and Lenders
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to the agents or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc as Agent and Trustee for Itself and the Other Lenders
    Transaktionen
    • 12. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Copyright security agreement
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 21. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any grantor to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under a) all registered copyrights b) all copyright licenses c) all renewals or extensions of the copyrights and copyright licenses d) all products and proceeds of the copyrights copyright licenses and fees and royalties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unova, Inc
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Copyright security agreement
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 21. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under a) all registered copyrights b) all copyright licenses c) all renewals or extensions of the copyrights and copyright licenses d) all products and proceeds of the copyrights copyright licenses and fees and royalties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Patent and trademark security agreement
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 21. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any grantor to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under: a) all filed patents and patent applications b) all patent licenses c) all filed trademarks service marks trademark or service mark d) all trademarks and trademark licenses. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unova, Inc
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Patent and trademark security agreement
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 21. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under: a) all filed patents and patent applications b) all patent licenses c) all filed trademarks service marks trademark or service mark d) all trademarks and trademark licenses. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 21. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any grantor to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest on to and under all personal property and other assets including all accounts all chattel paper, all documents and all general intangibles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unova, Inc
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 21. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest on to and under all personal property and other assets including all accounts all chattel paper, all documents and all general intangibles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance, Llc
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 20. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property at birmingham t/no WM542569, l/h property at birmingham t/no WM645192, f/h property at newmarket t/no SK24214 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unova, Inc.
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 19. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and cincinnati machine limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property located at birmingham t/no WM542569, and the l/h property located at birmingham t/no WM645192 the f/h property located at newmarket t/no SK24214 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mag International Industrial Automation Systems S.A.R.L
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 2005
    Geliefert am 19. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any credit party to the agent or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property located at birmingham t/no WM542569, and the l/h property located at birmingham t/no WM645192 the f/h property located at newmarket t/no SK24214 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Silver Point Finance Llc
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LAMB TECHNICON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Dez. 2012Aufgelöst am
    04. Okt. 2010Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Guy Edward Brooke Mander
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Praktiker
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Lynn Robert Bailey
    Baker Tilly
    St Philips Point
    B2 5AF Temple Row
    Birmingham
    Praktiker
    Baker Tilly
    St Philips Point
    B2 5AF Temple Row
    Birmingham
    Graham Paul Bushby
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Praktiker
    Baker Tilly Restructuring And Recovery Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0