FOREST INNS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFOREST INNS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05336808
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FOREST INNS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich FOREST INNS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    100 George Street
    W1U 8NU London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FOREST INNS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NORHAM HOUSE 1007 LIMITED19. Jan. 200519. Jan. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOREST INNS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für FOREST INNS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    20 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2023

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2022

    19 SeitenLIQ03

    Rücktritt eines Liquidators

    4 SeitenLIQ06

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2021

    14 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 02. März 2020

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Herbert Surphlis als Geschäftsführer am 26. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Martin Francis Magee als Geschäftsführer am 26. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Herbert Surphlis am 01. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr James Stephen Higgins am 20. Juli 2017

    1 SeitenCH03

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017

    10 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 053368080010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 053368080009 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Muckle Llp Time Central 32 Gallowgate Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE1 4BF zum 100 George Street London W1U 8NU am 04. Okt. 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 11. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FOREST INNS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HIGGINS, James Stephen
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Sekretär
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Northern IrishCompany Director116620060001
    LAVERTY, Eamonn Francis
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director164594500001
    LAVERTY, Mary Margaret
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director100394510001
    LAVERTY, Eamonn Francis
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Sekretär
    Drumcairne House
    18 Drumcairne Road
    BT71 5AD Stewartstown
    Co Tyrone
    Northern Ireland
    Northern IrishCompany Director164594500001
    NORHAM HOUSE SECRETARY LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    Sekretär
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    101749170001
    MAGEE, Martin Francis
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Geschäftsführer
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Northern IrelandNorthern IrishCompany Director105879500001
    SURPHLIS, Stephen Herbert
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Geschäftsführer
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Northern IrelandBritishCompany Director116861100005
    NORHAM HOUSE DIRECTOR LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    101749130001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOREST INNS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Eamonn Francis Laverty
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    06. Apr. 2016
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Nein
    Nationalität: Northern Irish
    Staatsangehörigkeit: Northern Ireland
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mrs Mary Margaret Laverty
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    06. Apr. 2016
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    England
    Nein
    Nationalität: Northern Irish
    Staatsangehörigkeit: Northern Ireland
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat FOREST INNS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 15. Dez. 2015
    Geliefert am 18. Dez. 2015
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Security Agent
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Juni 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Aug. 2015
    Geliefert am 04. Sept. 2015
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Security Agent
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Juni 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Bank account charge
    Erstellt am 24. Nov. 2011
    Geliefert am 30. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interests and rights in or to any money at any time standing to the credit of any controlled account. By way of floating charge all assets. Account no: 16112912. 62964649.
    Berechtigte Personen
    • National Asset Loan Management Limited as Security Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2011
    Geliefert am 30. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land being jury's inn waterfront plaza nottingham t/no NT424258 assignment the insurance policies, the hedging agreements and all rental and other income fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2011
    Geliefert am 30. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor (except as guarantor for the charging company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. L/h land being jury's inn, waterfront plaza, london road, nottingham t/no NT424258 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Asset Loan Management Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Okt. 2009
    Geliefert am 04. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment of rents
    Erstellt am 25. Juli 2006
    Geliefert am 11. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit and the rental account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juli 2006
    Geliefert am 11. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land on the west side of london road nottingham. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 25. Juli 2006
    Geliefert am 11. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The benefit and interest in the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 25. Juli 2006
    Geliefert am 11. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The benefit and interest in the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat FOREST INNS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Apr. 2024Soll aufgelöst werden am
    02. März 2020Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Grainne Quinn
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    Northern Ireland
    Praktiker
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    Northern Ireland
    Geraldine Cahill
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    County Londonderry
    Praktiker
    The Diamond Centre Market Street
    BT45 6ED Magherafelt Derry
    County Londonderry

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0