HALO INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHALO INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05362502
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HALO INVESTMENTS LIMITED?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HALO INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Regency House
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALO INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für HALO INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2020

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2019

    5 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Walker Banks am 17. Juni 2019

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2018

    7 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Feb. 2018 bis 31. Mai 2018

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Mr Jeremy Walker Banks als Direktor am 12. Feb. 2018

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Lynne Garsden als Geschäftsführer am 27. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Walker Banks als Sekretär am 27. Juli 2017

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Walker Banks als Geschäftsführer am 27. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von HALO INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BANKS, Jeremy Walker
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    Geschäftsführer
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United KingdomBritish106584870005
    MARSHALL, Paul Anthony
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    EnglandBritish109989680001
    BANKS, Jeremy Walker
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    Sekretär
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    British106584870003
    R S NOMINEES LIMITED
    1st Floor Didsbury House
    748 Wilmslow Road
    M20 2DW Didsbury
    Manchester
    Sekretär
    1st Floor Didsbury House
    748 Wilmslow Road
    M20 2DW Didsbury
    Manchester
    52646340002
    BANKS, Jeremy Walker
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish106584870003
    GARSDEN, Lynne
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    United Kingdom
    EnglandBritish86933130001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HALO INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Paul Anthony Marshall
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    06. Apr. 2016
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat HALO INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Juli 2013
    Geliefert am 23. Juli 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    K/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Juli 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Juli 2013
    Geliefert am 23. Juli 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Juli 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 07. Nov. 2008
    Geliefert am 12. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The exclusive right to receive rent.
    Berechtigte Personen
    • National Counties Building Society
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 07. Nov. 2008
    Geliefert am 12. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a pizza express restaurant, 16 monarch quay, pavilion building, kings waterfront, liverpool t/no MS540077 goodwill and the benefit of all licences, floating charge all other assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Counties Building Society
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 2008
    Geliefert am 17. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 1002 1003 and 1004 wingates westhoughton t/no GM880231 together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, the goodwill of any business carried on at the property, the benefit of all licences & registration required in the running of such a business (see image for full details).
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juni 2007
    Geliefert am 04. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H the pavilion building kings waterfront liverpool.
    Berechtigte Personen
    • G & J Seddon Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Juni 2007
    Geliefert am 27. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 3, shepcote, enterprise park, sheff. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 27. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Apr. 2007
    Geliefert am 17. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a unit 2 marlborough court marlborough way haydock part. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Nov. 2006
    Geliefert am 22. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H k/a bradford road keighley t/n WYK812015. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Jan. 2006
    Geliefert am 14. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land k/a plot 10 coppicemere drive crewe business park cheshire t/no CH509110. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2005
    Geliefert am 01. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pbn Management Limited
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Aug. 2005
    Geliefert am 01. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a proco print, unit 9, parkway close, sheffield t/no SYK400632.
    Berechtigte Personen
    • Pbn Management Limited
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2005
    Geliefert am 25. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the southwest side of parkway close, sheffield, south yorkshire t/no. SYK400632 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Aug. 2005
    Geliefert am 25. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the southwest side of parkway close, sheffield, south yorkshire t/no. SYK400632. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0