HALO INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HALO INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05362502 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HALO INVESTMENTS LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich HALO INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Regency House 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALO INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HALO INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2019 | 5 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Walker Banks am 17. Juni 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2018 | 7 Seiten | AA | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Feb. 2018 bis 31. Mai 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Ernennung von Mr Jeremy Walker Banks als Direktor am 12. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Lynne Garsden als Geschäftsführer am 27. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Walker Banks als Sekretär am 27. Juli 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Walker Banks als Geschäftsführer am 27. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von HALO INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKS, Jeremy Walker | Geschäftsführer | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House | United Kingdom | British | 106584870005 | |||||
| MARSHALL, Paul Anthony | Geschäftsführer | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House United Kingdom | England | British | 109989680001 | |||||
| BANKS, Jeremy Walker | Sekretär | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House United Kingdom | British | 106584870003 | ||||||
| R S NOMINEES LIMITED | Sekretär | 1st Floor Didsbury House 748 Wilmslow Road M20 2DW Didsbury Manchester | 52646340002 | |||||||
| BANKS, Jeremy Walker | Geschäftsführer | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 106584870003 | |||||
| GARSDEN, Lynne | Geschäftsführer | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House United Kingdom | England | British | 86933130001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HALO INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Anthony Marshall | 06. Apr. 2016 | 45-51 Chorley New Road BL1 4QR Bolton Regency House | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat HALO INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 18. Juli 2013 Geliefert am 23. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung K/A. notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. Juli 2013 Geliefert am 23. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of rental income | Erstellt am 07. Nov. 2008 Geliefert am 12. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The exclusive right to receive rent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 07. Nov. 2008 Geliefert am 12. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H premises k/a pizza express restaurant, 16 monarch quay, pavilion building, kings waterfront, liverpool t/no MS540077 goodwill and the benefit of all licences, floating charge all other assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Apr. 2008 Geliefert am 17. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1002 1003 and 1004 wingates westhoughton t/no GM880231 together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, the goodwill of any business carried on at the property, the benefit of all licences & registration required in the running of such a business (see image for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juni 2007 Geliefert am 04. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H the pavilion building kings waterfront liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juni 2007 Geliefert am 27. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Unit 3, shepcote, enterprise park, sheff. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Apr. 2007 Geliefert am 17. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a unit 2 marlborough court marlborough way haydock part. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Nov. 2006 Geliefert am 22. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H k/a bradford road keighley t/n WYK812015. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 2006 Geliefert am 14. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land k/a plot 10 coppicemere drive crewe business park cheshire t/no CH509110. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2005 Geliefert am 01. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Aug. 2005 Geliefert am 01. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The property k/a proco print, unit 9, parkway close, sheffield t/no SYK400632. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2005 Geliefert am 25. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings on the southwest side of parkway close, sheffield, south yorkshire t/no. SYK400632 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Aug. 2005 Geliefert am 25. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings on the southwest side of parkway close, sheffield, south yorkshire t/no. SYK400632. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0