DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05364898
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Gibson Booth
    15 Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    South Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    57 CHANNELS LIMITED15. Feb. 200515. Feb. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    15 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Millshaw, Ring Road Beeston Leeds West Yorkshire LS11 8EG zum C/O Gibson Booth 15 Victoria Road Barnsley South Yorkshire S70 2BB am 18. Apr. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 28. März 2019

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beendigung der Bestellung von Paul Terence Millington als Geschäftsführer am 25. März 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Robert Marshall als Direktor am 25. März 2019

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Roderick Michael Evans als Geschäftsführer am 18. Dez. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert Marshall als Sekretär am 18. Dez. 2018

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    25 SeitenAA

    Notification of Evans Dakota Services Limited as a person with significant control on 16. März 2018

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Helga Ingeborg Evans as a person with significant control on 16. März 2018

    1 SeitenPSC07

    Cessation of Michael White Evans as a person with significant control on 16. März 2018

    1 SeitenPSC07

    Cessation of Sanne Group Plc as a person with significant control on 16. März 2018

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 053648980005 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 053648980006 vollständig

    4 SeitenMR04

    Change of details for Mr Michael White Evans as a person with significant control on 30. Juni 2017

    2 SeitenPSC04

    Change of details for Mrs Helga Ingeborg Evans as a person with significant control on 30. Juni 2017

    2 SeitenPSC04

    Wer sind die Geschäftsführer von DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARSHALL, Robert
    Millshaw
    LS11 8EG Leeds
    Evans Property Group
    England
    Geschäftsführer
    Millshaw
    LS11 8EG Leeds
    Evans Property Group
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant190577840001
    MARSHALL, Robert
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    225858730001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Sekretär
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    BritishAccountant58693930003
    TATE, Christopher Ian
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    202021170001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BELL, John Drummond
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector63940900003
    BOYTON, Denis
    6 Orchard Drive
    Giffnock
    G46 7NR Glasgow
    Geschäftsführer
    6 Orchard Drive
    Giffnock
    G46 7NR Glasgow
    ScotlandBritishDirector80350370001
    EVANS, Roderick Michael
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director40175270005
    MARCUS, Ian
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director171431630001
    MCCULLOCH, Kenneth Wilfred
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    Geschäftsführer
    69 Kelvin Court
    G12 0AG Glasgow
    ScotlandBritishDirector37947170001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Geschäftsführer
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritishAccountant58693930003
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    16. März 2018
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer09275301
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Mr Michael White Evans
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    06. Apr. 2016
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Monaco
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten eines Trusts auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, und die Treuhänder dieses Trusts (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten eines Trusts auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, und die Treuhänder dieses Trusts (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mrs Helga Ingeborg Evans
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    06. Apr. 2016
    Millshaw, Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    West Yorkshire
    Ja
    Nationalität: German
    Staatsangehörigkeit: Monaco
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten eines Trusts auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, und die Treuhänder dieses Trusts (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten eines Trusts auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, und die Treuhänder dieses Trusts (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Sanne Group Plc
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    06. Apr. 2016
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Ja
    RechtsformPublic Limited Company
    RegistrierungslandJersey
    RechtsgrundlageJersey Law
    RegistrierungsortJfsc Companies Registry
    Registrierungsnummer117625
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    199
    Scotland
    06. Apr. 2016
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    199
    Scotland
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc251005
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Nov. 2015
    Geliefert am 04. Nov. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Piece of ground extending to 1.61 acres or thereby at ferry muir south queensferry said tenant's interest in which lease is reistered in the land register of scotland under t/no WLN37112.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 11. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 23. Okt. 2015
    Geliefert am 30. Okt. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The company (to the intent that the security hereby created shall rank as a continuing security in favour of aib group (UK) P.L.C.) hereby charges with full title guarantee to aib group (UK) P.L.C. for the payment and discharge of the secured obligations (as defined in the debenture):. (1) by way of legal mortgage all estates or interests in any freehold and/or leasehold property referred to in the schedule of the debenture and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery owned by or charged to the company and from time to time on or in such freehold and/or leasehold property (together "the legally mortgaged property") and/or the proceeds of sale of the legally mortgaged property;. (2) by way of fixed equitable charge all estates or interests in any freehold and leasehold property (except the legally mortgaged property) now and at any time during the continuance of this security belonging to or charged to the company and all licences now or hereafter held by the company to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land to which the company is or may become a party or otherwise entitled and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery owned by the company and from time to time on or in any freehold or leasehold property an interest in which is charged hereunder (together "the equitably charged property") and/or the proceeds of sale of the equitably charged property; and. (3) by way of fixed charge the goodwill and the uncalled capital of the company now or at any time hereafter in existence and future calls (whether made by the direction of the company or a receiver, an administrator or a liquidator (as respectively defined in the debenture)) and the licences, patents, patent applications, trade names and rights in trademarks, copyrights, whether registered or not, rights in the nature of copyright, registered designs, know how, inventions, rights in confidential information, service marks and all other intellectual property rights now or at any time during the continuance of this security belonging to the company.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 11. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge by way of assignment
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 28. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed legal charge all of its present and future rights title and interest in and to the management contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 28. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 28. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 28. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over accounts
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 28. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums deposited or to be deposited by the company in an account of the company and any other sums or sums which are from time to time deposited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Bank P.L.C.
    Transaktionen
    • 28. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 27/03/06 and
    Erstellt am 27. Jan. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenant's interest in the lease over that area or piece of ground extending to 1.61 acres or thereby at ferry muir south queensferry t/no WLN5064.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat DAKOTA FORTH BRIDGE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. März 2019Beginn der Liquidation
    20. März 2020Soll aufgelöst werden am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Christopher Wetton
    15 Victoria Road
    Barnsley
    S70 2BB South Yorkshire
    Praktiker
    15 Victoria Road
    Barnsley
    S70 2BB South Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0