BROMSGROVE STREET LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BROMSGROVE STREET LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05365574 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BROMSGROVE STREET LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich BROMSGROVE STREET LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bdo Llp 125 Colmore Row B3 3SD Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BROMSGROVE STREET LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BROMSGROVE STREET LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR United Kingdom am 04. Okt. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Colin Richard Clapham als Sekretär am 12. Jan. 2012 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Lorraine Atterbury als Sekretär am 12. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon James Brown am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ingrid Ruth Skinner am 22. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Andrew Reid am 01. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Andrew Reid am 21. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 80 New Bond Street London W1S 1SB am 05. Apr. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Karen Lorraine Atterbury am 28. März 2011 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ingrid Ruth Gelley am 12. Okt. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Vahid Alaghband am 27. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BROMSGROVE STREET LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAPHAM, Colin Richard | Sekretär | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 166216640001 | |||||||
| ALAGHBAND, Nader | Geschäftsführer | 31-32 Kensington Park Gardens W11 2QS London Flat 6 | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 120915300001 | |||||
| ALAGHBAND, Vahid | Geschäftsführer | Stanhope Gate W1K 1AH London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 5674390001 | |||||
| BROWN, Simon James | Geschäftsführer | 101-135 Kings Road CM14 4DR Brentwood Kings House Essex United Kingdom | Britain | British | 46898530007 | |||||
| REID, David Andrew | Geschäftsführer | Stanhope Gate W1K 1AH London 5 United Kingdom | England | British | 155269870001 | |||||
| SKINNER, Ingrid Ruth | Geschäftsführer | New Bond Street W1S 1SB London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 133605100002 | |||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Sekretär | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Sekretär | Chestnut Drive HP4 2JL Berkhamsted 11 Hertfordshire United Kingdom | Other | 135442010007 | ||||||
| CARR, Peter Anthony | Sekretär | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CARR, Peter Anthony | Sekretär | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Sekretär | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| JORDAN, James John | Sekretär | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| PHILLIPS, James | Sekretär | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| CML SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Piries Place RH12 1EH Horsham West Sussex | 74740960001 | |||||||
| ATKIN, Peter Neil | Geschäftsführer | Hurst Dene New Place RH20 1AT Pulborough West Sussex | United Kingdom | British | 10294000001 | |||||
| COOK, Richard John | Geschäftsführer | 23 Hawthorne Drive School Aycliffe DL5 6GH Darlington County Durham | United Kingdom | British | 178588500001 | |||||
| DODDS, Graeme James | Geschäftsführer | 16 Second Avenue CO13 9ER Frinton On Sea Essex | England | British | 146495490001 | |||||
| FREEMAN, Emma Louise | Geschäftsführer | 13 Beverley Path Barnes SW13 0AL London | British | 113500840001 | ||||||
| HAYS, Richard William | Geschäftsführer | 2 Linfold Close CM7 9FB Braintree Essex | United Kingdom | British | 90336020002 | |||||
| HAYS, Richard William | Geschäftsführer | 2 Linfold Close CM7 9FB Braintree Essex | United Kingdom | British | 90336020002 | |||||
| MARTIN, Roderick Adrian | Geschäftsführer | 30 Juniper Close RH8 0RX Oxted Surrey | British | 105672190002 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Geschäftsführer | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 | |||||
| SOUTHCOMBE, Michael Arthur | Geschäftsführer | 5 Mackie Avenue BN6 8NH Hassocks West Sussex | United Kingdom | British | 33313590001 | |||||
| TILLOTSON, David Gregory | Geschäftsführer | Stubbards Croft Vine Street CM7 4SR Great Bardfield Essex | United Kingdom | British | 118374930001 | |||||
| TURNER, Niki Jayne | Geschäftsführer | 76 Rydal Gardens TW3 2JH Whitton Middlesex | British | 99481440001 | ||||||
| WOOLSEY, Richard John | Geschäftsführer | 33 Victoria Wharf 46 Narrow Street E14 8DD London | England | British | 111162100001 |
Hat BROMSGROVE STREET LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment | Erstellt am 27. Sept. 2007 Geliefert am 03. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its entire right title and interest in and to the contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 06. Sept. 2007 Geliefert am 07. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its entire right title and interest in and to the contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Aug. 2007 Geliefert am 18. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings at hurst street bromsgrove street pershore street and claybrook street birmingham t/n WM857697. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Aug. 2007 Geliefert am 18. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BROMSGROVE STREET LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0