RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED

RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05396885
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp The Spark
    Draymans Way, Newcastle Helix
    NE4 5DE Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RESPONSIVE INVESTMENTS LIMITED02. Aug. 200502. Aug. 2005
    NORHAM HOUSE 1020 LIMITED17. März 200517. März 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2023 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2023

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Draymans Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DE verlegt

    1 SeitenAD04

    Change of details for Reece Group Limited as a person with significant control on 17. Nov. 2022

    2 SeitenPSC05

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Armstrong Works Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE15 6UX United Kingdom zum C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Draymans Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DE am 17. Nov. 2022

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    17 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Gordon Macdonald als Geschäftsführer am 06. Dez. 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    16 SeitenAA

    Ernennung von Gordon Macdonald als Direktor am 01. Juli 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Graeme Cook als Geschäftsführer am 05. Apr. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England zum C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX geändert

    1 SeitenAD02

    Wer sind die Geschäftsführer von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REECE, John Peter
    The Spark
    Draymans Way, Newcastle Helix
    NE4 5DE Newcastle Upon Tyne
    C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Spark
    Draymans Way, Newcastle Helix
    NE4 5DE Newcastle Upon Tyne
    C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish10546590006
    BORRELL, Arthur James Peter
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    Sekretär
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    British47328860003
    KITE, Philip John
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Sekretär
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    174185280001
    SIMPSON, Steven Norman
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    British49838890001
    NORHAM HOUSE SECRETARY LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    Bevollmächtigter Sekretär
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    900029260001
    ANDERTON, Roger David
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    United KingdomBritish99166030001
    BERNARD, Peter Barry
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    Wincomblee Road
    England
    Geschäftsführer
    Walker
    NE6 3QS Newcastle Upon Tyne
    Wincomblee Road
    England
    United KingdomBritish19362840002
    BORRELL, Arthur James Peter
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    EnglandBritish47328860003
    COOK, Graeme
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    United KingdomBritish208180310001
    KITE, Philip John
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    United KingdomBritish166586060001
    MACDONALD, Gordon
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    EnglandBritish262036760001
    SIMPSON, Steven Norman
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    EnglandBritish49838890001
    THOMPSON, Christopher Scott
    Elmfield Road
    Gosforth
    NE3 4BF Newcastle Upon Tyne
    98
    Geschäftsführer
    Elmfield Road
    Gosforth
    NE3 4BF Newcastle Upon Tyne
    98
    United KingdomBritish42840520008
    TORDAY, Paul Lazslo
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Kingsway South
    Team Valley
    NE11 0SH Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish86896540001
    NORHAM HOUSE DIRECTOR LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    900029250001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    The Spark
    Draymans Way, Newcastle Helix
    NE4 5DE Newcastle Upon Tyne
    C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    The Spark
    Draymans Way, Newcastle Helix
    NE4 5DE Newcastle Upon Tyne
    C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer7630662
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 05. Juni 2009
    Geliefert am 06. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set- off agreement
    Erstellt am 18. Sept. 2008
    Geliefert am 19. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 18. Sept. 2008
    Geliefert am 19. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    All assets debenture
    Erstellt am 30. Juni 2005
    Geliefert am 19. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0