RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05396885 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp The Spark Draymans Way, Newcastle Helix NE4 5DE Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RESPONSIVE INVESTMENTS LIMITED | 02. Aug. 2005 | 02. Aug. 2005 |
| NORHAM HOUSE 1020 LIMITED | 17. März 2005 | 17. März 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Feb. 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Draymans Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DE verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Change of details for Reece Group Limited as a person with significant control on 17. Nov. 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Armstrong Works Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE15 6UX United Kingdom zum C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Draymans Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DE am 17. Nov. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gordon Macdonald als Geschäftsführer am 06. Dez. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Gordon Macdonald als Direktor am 01. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graeme Cook als Geschäftsführer am 05. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England zum C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REECE, John Peter | Geschäftsführer | The Spark Draymans Way, Newcastle Helix NE4 5DE Newcastle Upon Tyne C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 10546590006 | |||||
| BORRELL, Arthur James Peter | Sekretär | Pinedale Wallace Avenue NE16 4SX Whickham County Durham | British | 47328860003 | ||||||
| KITE, Philip John | Sekretär | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | 174185280001 | |||||||
| SIMPSON, Steven Norman | Sekretär | Kingsway South Team Valley NE11 0SH Gateshead Tyne & Wear | British | 49838890001 | ||||||
| NORHAM HOUSE SECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Norham House 12 New Bridge Street West NE1 8AS Newcastle Upon Tyne Tyne &Wear | 900029260001 | |||||||
| ANDERTON, Roger David | Geschäftsführer | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | United Kingdom | British | 99166030001 | |||||
| BERNARD, Peter Barry | Geschäftsführer | Walker NE6 3QS Newcastle Upon Tyne Wincomblee Road England | United Kingdom | British | 19362840002 | |||||
| BORRELL, Arthur James Peter | Geschäftsführer | Kingsway South Team Valley NE11 0SH Gateshead Tyne & Wear | England | British | 47328860003 | |||||
| COOK, Graeme | Geschäftsführer | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | United Kingdom | British | 208180310001 | |||||
| KITE, Philip John | Geschäftsführer | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | United Kingdom | British | 166586060001 | |||||
| MACDONALD, Gordon | Geschäftsführer | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | England | British | 262036760001 | |||||
| SIMPSON, Steven Norman | Geschäftsführer | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | England | British | 49838890001 | |||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Geschäftsführer | Elmfield Road Gosforth NE3 4BF Newcastle Upon Tyne 98 | United Kingdom | British | 42840520008 | |||||
| TORDAY, Paul Lazslo | Geschäftsführer | Kingsway South Team Valley NE11 0SH Gateshead Tyne & Wear | United Kingdom | British | 86896540001 | |||||
| NORHAM HOUSE DIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Norham House 12 New Bridge Street West NE1 8AS Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | 900029250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reece Group Limited | 06. Apr. 2016 | The Spark Draymans Way, Newcastle Helix NE4 5DE Newcastle Upon Tyne C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat RESPONSIVE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 05. Juni 2009 Geliefert am 06. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set- off agreement | Erstellt am 18. Sept. 2008 Geliefert am 19. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed & floating charge | Erstellt am 18. Sept. 2008 Geliefert am 19. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 30. Juni 2005 Geliefert am 19. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0