BRABCO 516 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRABCO 516 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05399981
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRABCO 516 LIMITED?

    • (4521) /

    Wo befindet sich BRABCO 516 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRABCO 516 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRABCO 516 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2023

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2023

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2022

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2019

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2022

    6 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 6th Floor 3 Hardman Street Spinningfields Manchester Lancashire M3 3AT zum C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH am 28. Okt. 2021

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2021

    11 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2021

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2021

    5 Seiten4.68

    Tod eines Liquidators

    3 SeitenLIQ09

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2018

    5 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 SeitenLIQ MISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Aug. 2017

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    18 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Feb. 2017

    2 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Sec. Of State Cert of Release of Liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of states certificate of release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Wer sind die Geschäftsführer von BRABCO 516 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BLAGBROUGH, Anthony Robert
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    BritishDirector65700160001
    BLAGBROUGH, Anthony Robert
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    65 Shaw Road
    SK4 4AL Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector65700160001
    BONNETTE, Stewart
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    EnglandBritishDirector78254910003
    HARDMAN, Raymond Leslie
    85 Seal Road
    Bramhall
    SK7 2LE Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    85 Seal Road
    Bramhall
    SK7 2LE Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector2431510001
    TOCK, Brian
    Swallows Barn
    Willeymoor Lane
    SY13 4QN Tushingham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Swallows Barn
    Willeymoor Lane
    SY13 4QN Tushingham
    Cheshire
    EnglandBritishDirector107729260001
    BONNETTE, Stewart
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    Sekretär
    7 Bracknel Way
    L39 3RQ Aughton
    Lancashire
    BritishDirector78254910003
    BRABNERS SECRETARIES LIMITED
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79875300001
    HOUGHTON, David Lee
    Woodbank Cottage
    Harthill Road
    CH3 9NU Burwardsley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Woodbank Cottage
    Harthill Road
    CH3 9NU Burwardsley
    Cheshire
    BritishAca79694590001
    BRABNERS DIRECTORS LIMITED
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    C/O Brabners Chaffe Street
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79875290001

    Hat BRABCO 516 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignment of bank account
    Erstellt am 19. Dez. 2008
    Geliefert am 30. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its present and future right,title and interest in and to the following the security account,the account balance see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No.3 a Limited Partnership Acting by Its General Partner Afm Merseyside Ventures Limited
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Erstellt am 29. Nov. 2007
    Geliefert am 06. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the policy being life assured: mr s bonnette. Insurer: axa sun life. Policy no: 32558275. sum assured: £554,420 term: 5 years. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No 2
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Erstellt am 29. Nov. 2007
    Geliefert am 06. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the policy being life assured: mr a r blagbrough. Insurer: scottish life. Policy no: L0191239582. Sum assured: £554,420 term: 5 years. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No 2
    Transaktionen
    • 06. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed to a debenture dated 28 june 2006 and
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 15. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital copyrights chattels stocks shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No 3 Acting by Its General Partner Afm Merseysideventures Limited and Alliance Fund Managers Nominees Limited
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Erstellt am 30. Juli 2007
    Geliefert am 15. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Insurer: axa policy no: 32558275 life assured: stewart bonnette sum assured: £554420 term: 5 years commencement date: 30/03/07, insurer: scottish equitable policy no: L0191239582 life assured: anthony robert blagbrough sum assured: £554420 term: 5 years commencement date: 26/09/06. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No 3 Acting by Its General Partner Afm Merseysideventures Limited and Alliance Fund Managers Nominees Limited
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 2006
    Geliefert am 01. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all future f/h and l/h property the goodwill and its uncalled capital all receivables by way of first floating charge all its undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever situates, both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No 3, a Limited Liability Partnership, Acting by Itsd
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No 3, a Limited Liability Partnership, Acting by Its General Partner, Afm Merseyside Ventures Limite
    Transaktionen
    • 01. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Erstellt am 28. Sept. 2005
    Geliefert am 04. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Entire right title and interest in and to the policy of stewart bonnette dated 8 july 2005 for the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 23. Aug. 2005
    Geliefert am 26. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of the company's right title and interest in and to the insurance policy taken out on the life of stewart bonette with axa policy number 32354937 for the sum assured of £740,000 and for a term of 5 years. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No.3
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 23. Aug. 2005
    Geliefert am 26. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the insurance policy taken out on the life of stewart bonnette with axa policy number 32355215 sum assured £300,000 and for a term of five years. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No.2
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Erstellt am 11. Aug. 2005
    Geliefert am 18. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the policy and all companys rights in relation to the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juli 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juli 2005
    Geliefert am 13. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund No. 2
    Transaktionen
    • 13. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat BRABCO 516 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Feb. 2010Beginn der Liquidation
    07. Juli 2024Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dermot Justin Power
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Tracey Lee Pye
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Edward Terence Kerr
    Pannell House, 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Praktiker
    Pannell House, 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Lee Causer
    Bdo Llp Two Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp Two Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Patrick Alexander Lannagan
    3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Ian James Gould
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0