LC ACQUISITION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLC ACQUISITION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05416238
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LC ACQUISITION LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich LC ACQUISITION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Deloitte Llp
    1 Woodborough Road
    NG1 3FG Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LC ACQUISITION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AVATAR UK LIMITED06. Apr. 200506. Apr. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LC ACQUISITION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für LC ACQUISITION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Sept. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2012

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. März 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten287

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    4 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Sept. 2009

    LRESEX

    legacy

    2 Seiten288a

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 03. März 2007

    16 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    Wer sind die Geschäftsführer von LC ACQUISITION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HANN, Indira
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    British118446370001
    BAZANTAY, Emmanuel Patrick Serge
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    Geschäftsführer
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    French140033000001
    DUNKLEY, Andrew Albert
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    EnglandBritish134204360001
    LE CLAIR, Stefaan A
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Geschäftsführer
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Belgian123657490001
    LEE COOPER GLOBAL LLC
    Corporation Trust Co
    Corporation Trust Ctr 1209 Orange St
    Wilmington
    New Caste Delaware 19801
    Usa
    Geschäftsführer
    Corporation Trust Co
    Corporation Trust Ctr 1209 Orange St
    Wilmington
    New Caste Delaware 19801
    Usa
    105472550001
    MCGRATH, Caroline
    12 Camlet Way
    Barnet
    EN4 0LH Hertfordshire
    Sekretär
    12 Camlet Way
    Barnet
    EN4 0LH Hertfordshire
    British103465340001
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Sekretär
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Sekretär
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    DE LALANDE DE L'HERAUDIERE, Bruno Marie Jaques Goudon
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    Geschäftsführer
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    French121807520001
    DEGIOANNI, Thierry Antoine Michel
    10 Rue De Paris
    Orsay
    91400
    France
    Geschäftsführer
    10 Rue De Paris
    Orsay
    91400
    France
    French121806980001
    KHAITAN, Ajay
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    Geschäftsführer
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    United KingdomBritish87678640006
    PINFIELD, Scott
    Gillmoor House
    Dukes Hill, Gill Bank Road
    LS29 0AZ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gillmoor House
    Dukes Hill, Gill Bank Road
    LS29 0AZ Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomUnknown142349020001
    RIGG, Andrew
    26 Northbrook Road
    GU11 3HE Aldershot
    Hampshire
    Geschäftsführer
    26 Northbrook Road
    GU11 3HE Aldershot
    Hampshire
    EnglandBritish121787330001
    SELBY, John Edward Robertson
    113 Rodenhurst Road
    Clapham
    SW4 8AF London
    Geschäftsführer
    113 Rodenhurst Road
    Clapham
    SW4 8AF London
    British123468550001
    SUTCLIFFE, Simon
    1 Heron Court
    63 Lancaster Gate
    W2 3NJ London
    Geschäftsführer
    1 Heron Court
    63 Lancaster Gate
    W2 3NJ London
    British103465090001

    Hat LC ACQUISITION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of variation
    Erstellt am 12. Jan. 2007
    Geliefert am 27. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the obligors and/or lee cooper suisse sa to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 20. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commercial Finance Limited as Security Agent for Ge Factofrance Snc
    Transaktionen
    • 20. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 20. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Commerical Finance Limited (" the Security Holder")
    Transaktionen
    • 20. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Mai 2005
    Geliefert am 24. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lee Cooper Finance, Inc
    Transaktionen
    • 24. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LC ACQUISITION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Sept. 2009Beginn der Liquidation
    10. Apr. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Carlton Malcolm Siddle
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Christopher James Farrington
    Deloitte Llp
    1 Woodborough Road
    NG1 3FG Nottingham
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 Woodborough Road
    NG1 3FG Nottingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0