OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD
Überblick
Unternehmensname | OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05418732 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
- Allgemeinarztpraxen (86210) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Evergreen House The Edge Clowes Street M3 5NA Manchester United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CONCORDIA HEALTH LIMITED | 14. März 2006 | 14. März 2006 |
THE MEDICAL SHOP LIMITED | 08. Apr. 2005 | 08. Apr. 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 02. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 16. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 02. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2023 | 18 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Dr Richard Shama as a person with significant control on 07. Mai 2024 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Notification of Nadeem Saleem as a person with significant control on 07. Mai 2024 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Cessation of Jonathan Love as a person with significant control on 07. Mai 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Ernennung von Mr Nadeem Saleem als Direktor am 07. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Love als Geschäftsführer am 07. Mai 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Change of details for Dr Richard Shama as a person with significant control on 15. Jan. 2021 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Change of details for Jonathan Love as a person with significant control on 27. Nov. 2020 | 2 Seiten | PSC04 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Myerson Solicitors Grosvenor House Barrington Road Altrincham WA14 1HB England zum C/O Virtual Company Secretary Ltd 7 York Road Woking GU22 7XH geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Virtual Company Secretary Ltd 7 York Road Woking GU22 7XH United Kingdom zum Myerson Solicitors Grosvenor House Barrington Road Altrincham WA14 1HB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2023 bis 30. Juni 2023 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2022 | 20 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Great Queen Street Covent Garden London WC2B 5AH United Kingdom zum Evergreen House the Edge Clowes Street Manchester M3 5NA am 23. Mai 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2021 | 14 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 054187320004 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 054187320005 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 054187320001 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 054187320006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 054187320003 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Hobsons Alexandra House 43 Alexandra Street Nottingham NG5 1AY zum 16 Great Queen Street Covent Garden London WC2B 5AH am 07. Mai 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Toby Hurd als Geschäftsführer am 08. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALEEM, Nadeem | Geschäftsführer | The Edge Clowes Street M3 5NA Manchester Evergreen House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 217317630001 | ||||
SHAMA, Richard, Dr | Geschäftsführer | The Edge Clowes Street M3 5NA Manchester Evergreen House United Kingdom | United Kingdom | British | Medical Director | 280556380001 | ||||
BACON, Jane | Sekretär | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | 225160340001 | |||||||
HURD, Adam | Sekretär | 5 Porteus Place SW4 0AP London Flat 11 England | British | Marketing Director | 121595220002 | |||||
LOCKHART MIRAMS, Andrew Richard | Sekretär | Tavistock House South Tavistock Square WC1H 9LS London | British | Solicitor | 104466750001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BACON, Jane | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | England | British | Managing Director And Company Secretary | 249586020001 | ||||
CHISHOLM, John William, Doctor | Geschäftsführer | 5 Elmers End Road Anerley SE20 7ST London | United Kingdom | British | Medical Practitioner | 18490620004 | ||||
FRADD, Simon Oakley, Dr | Geschäftsführer | 67 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | United Kingdom | British | General Medical Practitioner | 32943920006 | ||||
HOLDSTOCK, Andrew Jack | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | United Kingdom | British | Financial Consultant | 252373860001 | ||||
HURD, Adam | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | United Kingdom | British | Managing Director | 121595220008 | ||||
HURD, Toby | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | England | British | Commercial Director | 111507000005 | ||||
LOCKHART MIRAMS, Andrew Richard | Geschäftsführer | Tavistock House South Tavistock Square WC1H 9LS London | British | Solicitor | 104466750001 | |||||
LOVE, Jonathan | Geschäftsführer | The Edge Clowes Street M3 5NA Manchester Evergreen House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 273723000001 | ||||
PARKIN, Rosalind | Geschäftsführer | Tavistock House South Tavistock Square WC1H 9LS London | British | Solicitor | 104466820001 | |||||
PINKERTON, Michael John | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | England | British | Consultant - Health Sector | 252061580001 | ||||
SCHRODER, Kate | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | England | British | Consultant, Turnaround And Transformation | 87198170003 | ||||
SEMKE, Philip Roland | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | England | British | Director | 266792760001 | ||||
SHARMA, Richard, Dr | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | England | British | Medical Director | 249586210001 | ||||
TWELVES, John Luke, Dr | Geschäftsführer | c/o Hobsons 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | United Kingdom | British | Director | 265316170001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Nadeem Saleem | 07. Mai 2024 | The Edge Clowes Street M3 5NA Manchester Evergreen House United Kingdom | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Dr Richard Shama | 15. Jan. 2021 | The Edge Clowes Street M3 5NA Manchester Evergreen House United Kingdom | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Jonathan Love | 27. Nov. 2020 | The Edge Clowes Street M3 5NA Manchester Evergreen House United Kingdom | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Dr John Luke Twelves | 27. Nov. 2020 | c/o HOBSONS 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Omnes Group Ltd | 18. Okt. 2019 | 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Concordia Health Holdings Llp | 06. Apr. 2016 | 43 Alexandra Street NG5 1AY Nottingham Alexandra House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat OMNES HEALTHCARE GENERAL PRACTICE LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 27. Nov. 2020 Geliefert am 11. Dez. 2020 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Nov. 2019 Geliefert am 14. Nov. 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 18. Okt. 2019 Geliefert am 07. Nov. 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 4.1 real property each chargor charges: (a) by way of first legal mortgage all real property described opposite its name in schedule 2; and (b) by way of first fixed charge, except to the extent mortgaged under clause 4.1(a) or that is a rack rent property, all other real property which it has at the date of this debenture or may subsequently acquire. 4.4 intellectual property each chargor charges by way of fixed charge its intellectual property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 18. Okt. 2019 Geliefert am 30. Okt. 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 4 mortgages and charges. 4.1 real property. Each chargor charges:. (A) by way of first legal mortgage all real property described opposite its name in schedule 2 (details of real property); and. (B) by way of first fixed charge, except to the extent mortgaged under clause 4.1(a) or that is a rack rent property, all other real property which it has at the date of this debenture or may subsequently acquire.. 4.4 intellectual property. Each chargor charges by way of fixed charge its intellectual property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 28. Apr. 2015 Geliefert am 07. Mai 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 16. Apr. 2015 Geliefert am 02. Mai 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0