CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED

CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAMDEN GROUP SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05418834
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED?

    • (5010) /

    Wo befindet sich CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O ZOLFO COOPER
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CAMDEN CORPORATE FLEET SERVICES LIMITED14. Nov. 200514. Nov. 2005
    CCFS (2005) LIMITED11. Okt. 200511. Okt. 2005
    PLOT TO BUILD LIMITED26. Apr. 200526. Apr. 2005
    BUIL A PLOT LIMITED08. Apr. 200508. Apr. 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Juli 2011

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Jan. 2011

    6 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    23 Seiten2.34B

    legacy

    1 Seiten287

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Aug. 2009

    16 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Vorschlag des Verwalters

    41 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    29 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed camden corporate fleet services LIMITED\certificate issued on 03/06/08
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    10 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBERTS, Nicolas Paul
    1 Wellington Road
    Chells
    SG2 9HR Stevenage
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Wellington Road
    Chells
    SG2 9HR Stevenage
    Hertfordshire
    Great BritainBritishDirector116840320001
    HAMMOND, David William
    6 Tannery Lane
    MK43 7AJ Odell
    Bedfordshire
    Sekretär
    6 Tannery Lane
    MK43 7AJ Odell
    Bedfordshire
    BritishDirector103235580001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Sekretär
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001
    ALLEN, Russell Charles
    28 Hollies Way
    Bushby
    LE7 9RJ Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    28 Hollies Way
    Bushby
    LE7 9RJ Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector127123920001
    BUTLER, Graham Mark
    17 Warren Bridge
    Oundle
    PE8 4DQ Peterborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    17 Warren Bridge
    Oundle
    PE8 4DQ Peterborough
    Northamptonshire
    United KingdomEnglishDirector48851020001
    DUNKLEY, Paul John
    Stoke Gap House
    Ashton Road Stoke Bruerne
    NN12 7SL Towcester
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Stoke Gap House
    Ashton Road Stoke Bruerne
    NN12 7SL Towcester
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector34398930002
    HAMMOND, David William
    6 Tannery Lane
    MK43 7AJ Odell
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    6 Tannery Lane
    MK43 7AJ Odell
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector103235580001
    MENNELL, Steven Robert
    Collingtree Park
    NN4 OUS Northampton
    7 Spyglass House
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Collingtree Park
    NN4 OUS Northampton
    7 Spyglass House
    Northamptonshire
    UkBritishDirector142851780001
    OBRIEN, Peter Andrew
    5 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AF Bedford
    Geschäftsführer
    5 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AF Bedford
    Great BritainBritishDirector97015900001
    RUTHERFORD, Simon Roy
    Hillside
    Lower Swell Road
    GL54 1LD Stow On The Wold
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Hillside
    Lower Swell Road
    GL54 1LD Stow On The Wold
    Gloucestershire
    BritishDirector93229770001
    SMITH, Deirdre
    1 Hillbeck Grove
    Middleton
    MK10 9JJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    1 Hillbeck Grove
    Middleton
    MK10 9JJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector116840210001
    WARDLE, Ian
    Bull Lane
    Chalfont St. Peter
    SL9 8RU Gerrards Cross
    Fairwinds
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Bull Lane
    Chalfont St. Peter
    SL9 8RU Gerrards Cross
    Fairwinds
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector138278030001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    47670880001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Geschäftsführer
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    Hat CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 10. Okt. 2007
    Geliefert am 24. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The benefit of all of its acquisition agreement claims,insurance policies,hedging agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC (Gmac)
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 15. Dez. 2006
    Geliefert am 20. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all such of the present and future property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Dez. 2006
    Geliefert am 20. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 17. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the comapny formerly known as ccfs (2005) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2003
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2003
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2003
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2003
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 02. Juli 2003
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property - london road, coventry CV3 4AA t/no WK221214, WM382503, WM382488. Leicester road, rugby t/no WK164006, WK233709, WK307744. Marton road, long itchington, stratford upon avon t/no WK304174. For details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 02. Juli 2003
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property - london road, coventry CV3 4AA t/no WK221214, WM382503, WM382488. Leicester road, rugby t/no WK164006, WK233709, WK307744. Marton road, long itchington, stratford upon avon t/no WK304174. For details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 02. Juli 2003
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 1999
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property - fitzroy house, 69-79 lake street, leighton buzzard t/no BD184301. F/h property - land and buildings north east side of lake street, leighton buzzard t/no BD844. L/h property - land north east side of lake street, leighton buzzard t/no BD195731. For details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. Juli 1999
    Erworben am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 25. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CAMDEN GROUP SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Feb. 2010Ende der Verwaltung
    03. Feb. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Fraser James Gray
    Kroll
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Kroll
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Alastair Paul Beveridge
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praktiker
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praktiker
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    2
    DatumTyp
    19. Okt. 2011Aufgelöst am
    01. Feb. 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Fraser James Gray
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Alastair Paul Beveridge
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0