CG THREE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CG THREE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05425483 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CG THREE LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CG THREE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Berkeley House 304 Regents Park Road N3 2JX London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CG THREE LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CG THREE LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 29. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für CG THREE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 25 Seiten | AA | ||
legacy | 43 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 27 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 28 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 22 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Michael David Watson als Direktor am 22. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 21 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Paul Hallam als Direktor am 10. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Daniel Lau als Sekretär am 10. Juli 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Hallam als Sekretär am 10. Juli 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Change of details for Dellmes Gr Limited as a person with significant control on 28. März 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 1 Seiten | CC04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Berkeley House 304 Regents Park Road London N3 2JY England zum Berkeley House 304 Regents Park Road London N3 2JX am 28. März 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Molteno House 302 Regents Park Road Finchley London N3 2JX zum Berkeley House 304 Regents Park Road London N3 2JY am 01. Nov. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Eintragung der Belastung 054254830006, erstellt am 17. Sept. 2018 | 173 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 20 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CG THREE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAU, Daniel | Sekretär | 304 Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | 261071290001 | |||||||
HALLAM, Paul | Geschäftsführer | 304 Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | England | British | Chartered Accountant | 260389200001 | ||||
MCGILL, Christopher Charles | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | England | British | Managing Director | 158021700001 | ||||
PROCTER, William Kenneth | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Accountant | 179204780001 | ||||
WATSON, Michael David | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Chartered Accountant | 63440350001 | ||||
HALLAM, Paul | Sekretär | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | 167212900001 | |||||||
RAPLEY, Ian | Sekretär | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | 104372330001 | ||||||
SHAMASH, David | Sekretär | 34 Floral Street WC2E 9DJ London | British | 7655800001 | ||||||
WOLFSON, Alan | Sekretär | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | 55840480004 | ||||||
PROCTER, William Kenneth | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | England | British | Director | 98678880016 | ||||
RAPLEY, Ian | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 | United Kingdom | British | None | 152894020001 | ||||
SHAMASH, Anthony David | Geschäftsführer | South Park TN11 8EA Penshurst Kent | England | British | Company Director | 142770950001 | ||||
WATSON, Michael David | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Chartered Accountant | 63440350001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CG THREE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dellmes Gr Limited | 06. Apr. 2016 | 304 Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CG THREE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 17. Sept. 2018 Geliefert am 26. Sept. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Freehold property known as 1/8 upney court, IG11 9JJ registered at hm land registry under title number EGL382383 and all the other plots of land listed in the instrument. For more details please refer to the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. März 2015 Geliefert am 17. März 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 2A cambray road london t/no TGL188999 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Nov. 2011 Geliefert am 09. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a charging company to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever and all monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including subsidiary shares, investments, intellectual property, goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 25. Okt. 2011 Geliefert am 08. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage each property and all fixtures on such property for the time being. By way of security for the all right, title and interest in and to each agreement see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 20. Dez. 2007 Geliefert am 08. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the legally mortgaged property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2007 Geliefert am 08. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0