OPTARE HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | OPTARE HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 05429847 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OPTARE HOLDINGS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich OPTARE HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 58 Hugh Street SW1V 4ER London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OPTARE HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
STEADY RHYME LIMITED | 20. Apr. 2005 | 20. Apr. 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPTARE HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OPTARE HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 3 Hurricane Way South Sherburn in Elmet Leeds North Yorkshire LS25 6PT zum 58 Hugh Street London SW1V 4ER am 12. Dez. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 37 Seiten | MA | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Nov. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Matthew Fickling als Geschäftsführer am 17. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Dr Andrew Charles Palmer als Direktor am 17. Juli 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Damian Butler als Geschäftsführer am 05. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Matthew Fickling am 08. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Richard Damian Butler als Direktor am 06. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OPTARE HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
PALMER, Andrew Charles | Geschäftsführer | Hugh Street SW1V 4ER London 58 | England | British | Director | 234209380001 | ||||||||
DUNN, Michael James | Sekretär | Lower Philips Road Whitebirk Industrial Estate BB1 5UD Blackburn, C/O Optare Plc Lancashire Uk | British | Accountant | 76706520003 | |||||||||
FOSSEY, Roger Nicholas | Sekretär | 2 Fieldhouse Close LS22 6UD Wetherby West Yorkshire | British | Group Finance Director | 37107310001 | |||||||||
PHILLIPS, Peter Brian | Sekretär | Hurricane Way South Sherburn In Elmet LS25 6PT Leeds Unit 3 North Yorkshire United Kingdom | 161210170001 | |||||||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
BRIAN, Andrew Peter | Geschäftsführer | Brook Grains Holme House Lane HX6 4HN Ripponden West Yorkshire | British | Director | 83287880002 | |||||||||
BUTLER, Richard Damian | Geschäftsführer | Sherburn In Elmet LS25 6PT Leeds Unit 3 Hurricane Way South North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 269704060001 | ||||||||
COOMBES, Robert Joseph | Geschäftsführer | 22 Riverdale Gardens LS23 6DZ Boston Spa Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 96099670001 | ||||||||
DUNN, Michael James | Geschäftsführer | Park Lane Roundhay LS8 2EH Leeds 35 West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 76706520003 | ||||||||
FICKLING, John Matthew | Geschäftsführer | Hurricane Way South Sherburn In Elmet LS25 6PT Leeds Unit 3 North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 135597750001 | ||||||||
FOSSEY, Roger Nicholas | Geschäftsführer | 2 Fieldhouse Close LS22 6UD Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 37107310001 | ||||||||
NARASIMHAN, Ramesh | Geschäftsführer | Hurricane Way South Sherburn In Elmet LS25 6PT Leeds Unit 3 North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | Director | 174507140001 | ||||||||
PHILLIPS, Peter Brian | Geschäftsführer | Hurricane Way South Sherburn In Elmet LS25 6PT Leeds Unit 3 North Yorkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 161134630001 | ||||||||
RICHARDSON, Russell | Geschäftsführer | The Gables Haverbreaks LA1 5BN Lancaster | England | British | Engineer | 25009210001 | ||||||||
STANLEY, Roy Robert Edward | Geschäftsführer | 16 Graham Park Road Gosforth NE3 4BH Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Director | 8609980002 | ||||||||
SUMNER, James Robert | Geschäftsführer | 34 Kensington Avenue Penwortham PR1 0EE Preston Lancashire | England | British | Director | 54180920002 | ||||||||
VASSALLO, Enrico | Geschäftsführer | Hurricane Way South Sherburn In Elmet LS25 6PT Leeds Unit 3 North Yorkshire United Kingdom | England | Italian | None | 234788440001 | ||||||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OPTARE HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamesstan Investments Limited | 06. Apr. 2016 | Sherburn In Elmet LS25 6PT Leeds Unit 3 Hurricane Way South North Yorkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für OPTARE HOLDINGS LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
08. Apr. 2017 | 16. Feb. 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat OPTARE HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 11. März 2008 Geliefert am 18. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. März 2008 Geliefert am 18. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings at denby way hellaby rotherham t/n SYK116639 & SYK342540 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 05. Jan. 2007 Geliefert am 13. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the north side of mansyon lane crossgate leeds t/no WYK335775. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 05. Jan. 2007 Geliefert am 13. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the south east & east side of denby way hellaby rotherham south yorkshire t/nos SYK116639 & SYK342540. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 05. Jan. 2007 Geliefert am 06. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land on the south east and east side of denby way hellaby rotherham south yorkshire t/nos SYK116639 and SYK342540 and f/h land and buildings on the north side of manston lane crossgates leeds west yorkshire t/no WYK335775 the benefit rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any share or membership certificates and corresponding signed share or membership transfer form(s), any goodwill, any rental and other money payable under any lease and any other payments in respect of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 05. Jan. 2007 Geliefert am 06. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land on the south east and east side of denby way hellaby rotherham south yorkshire t/nos SYK116639 and SYK342540 and f/h land and buildings on the north side of manston lane crossgates leeds west yorkshire t/no WYK335775 the benefit rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any share or membership certificates and corresponding signed share or membership transfer form(s), any goodwill, any rental and other money payable under any lease and any other payments in respect of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Juli 2005 Geliefert am 30. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat OPTARE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0