WIZARD BONDCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WIZARD BONDCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05447232 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WIZARD BONDCO LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WIZARD BONDCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Market Close Poole BH15 1NQ Dorset |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WIZARD BONDCO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WIZARD BONDCO LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für WIZARD BONDCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Okt. 2014
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 30. Okt. 2014
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 31. Okt. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Okt. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Christopher Carr als Geschäftsführer am 03. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas John Varney als Geschäftsführer am 03. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mrs Fiona Jane Rose als Direktor am 03. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 054472320006 | 79 Seiten | MR01 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WIZARD BONDCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMSTRONG, Colin North | Sekretär | Market Close BH15 1NQ Poole 3 Dorset | British | 172030620001 | ||||||
| ARMSTRONG, Colin North | Geschäftsführer | Market Close BH15 1NQ Poole 3 Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | 172030620001 | |||||
| ROSE, Fiona Jane | Geschäftsführer | 3 Market Close Poole BH15 1NQ Dorset | England | British | 93616410002 | |||||
| CARR, Andrew Christopher | Sekretär | Oakapple Cottage Oak Court Church Road Shillingstone DT11 0TT Blandford Forum Dorset | British | 65490970002 | ||||||
| CORBEN, Darcy | Sekretär | 3 Market Close BH15 1NQ Poole Dorset | British | 111442510002 | ||||||
| DAILLY, Andrew | Sekretär | 14 Bronson Road Raynes Park SW20 8DY London | British | 105982060001 | ||||||
| TOOTH, Matthew David | Sekretär | Flat 6 21 Cranley Gardens SW7 3BD London | British | 100150000001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | Park Avenue New York 345 Ny 10154 United States | Usa | American | 94259330002 | |||||
| BUCKLAND, James Lindsay Carnac | Geschäftsführer | Ashurst 5 Appold Street EC2A 2HA London | British | 104768550001 | ||||||
| CARR, Andrew Christopher | Geschäftsführer | 3 Market Close BH15 1NQ Poole Dorset | United Kingdom | British | 65490970003 | |||||
| DAILLY, Andrew | Geschäftsführer | 14 Bronson Road Raynes Park SW20 8DY London | British | 105982060001 | ||||||
| TOOTH, Matthew David | Geschäftsführer | Flat 6 21 Cranley Gardens SW7 3BD London | England | British | 100150000001 | |||||
| VARNEY, Nicholas John | Geschäftsführer | 3 Market Close BH15 1NQ Poole Dorset | England | British | 50480360003 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat WIZARD BONDCO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 28. Juni 2013 Geliefert am 03. Juli 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A second confirmatory security agreement | Erstellt am 24. Mai 2011 Geliefert am 31. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A confirmatory security agreement | Erstellt am 05. Aug. 2010 Geliefert am 20. Aug. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 26. Juni 2008 Geliefert am 11. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured italian creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 21. Mai 2007 Geliefert am 31. Mai 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured row creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 19. Aug. 2005 Geliefert am 31. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0