WIZARD BONDCO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWIZARD BONDCO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05447232
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WIZARD BONDCO LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich WIZARD BONDCO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WIZARD BONDCO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WIZARD BONDCO LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WIZARD BONDCO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 22. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 50.861001
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschlüsse

    Auth capital restriction removed 30/10/2014
    RES13
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    Capitalisation authority 30/10/2014
    RES14

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 50.861001
    4 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschlüsse

    Auth capital restriction revoked 30/10/2014
    RES13
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    Authority to capitalise 30/10/2014
    RES14

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 30. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 4,986,100.14
    4 SeitenSH01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 31. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 50.58
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 30. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 49.86
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account 30/10/2014
    RES13

    Beendigung der Bestellung von Andrew Christopher Carr als Geschäftsführer am 03. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas John Varney als Geschäftsführer am 03. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Fiona Jane Rose als Direktor am 03. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2013

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 4,986,099.14
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2012

    12 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Facilires agreement auth approved 24/06/2013
    RES13

    Eintragung der Belastung 054472320006

    79 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von WIZARD BONDCO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    Sekretär
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    British172030620001
    ARMSTRONG, Colin North
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Market Close
    BH15 1NQ Poole
    3
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritish172030620001
    ROSE, Fiona Jane
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    Geschäftsführer
    3 Market Close
    Poole
    BH15 1NQ Dorset
    EnglandBritish93616410002
    CARR, Andrew Christopher
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    Sekretär
    Oakapple Cottage Oak Court
    Church Road Shillingstone
    DT11 0TT Blandford Forum
    Dorset
    British65490970002
    CORBEN, Darcy
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Sekretär
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    British111442510002
    DAILLY, Andrew
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    Sekretär
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    British105982060001
    TOOTH, Matthew David
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    Sekretär
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    British100150000001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARATTA, Joseph Patrick
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    Geschäftsführer
    Park Avenue
    New York
    345
    Ny 10154
    United States
    UsaAmerican94259330002
    BUCKLAND, James Lindsay Carnac
    Ashurst
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Geschäftsführer
    Ashurst
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    British104768550001
    CARR, Andrew Christopher
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    United KingdomBritish65490970003
    DAILLY, Andrew
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    Geschäftsführer
    14 Bronson Road
    Raynes Park
    SW20 8DY London
    British105982060001
    TOOTH, Matthew David
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    Geschäftsführer
    Flat 6
    21 Cranley Gardens
    SW7 3BD London
    EnglandBritish100150000001
    VARNEY, Nicholas John
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    Geschäftsführer
    3 Market Close
    BH15 1NQ Poole
    Dorset
    EnglandBritish50480360003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat WIZARD BONDCO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. Juni 2013
    Geliefert am 03. Juli 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Unicredit Bank Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Senior Creditors (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 03. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A second confirmatory security agreement
    Erstellt am 24. Mai 2011
    Geliefert am 31. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unicredit Bank Ag London Branch
    Transaktionen
    • 31. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A confirmatory security agreement
    Erstellt am 05. Aug. 2010
    Geliefert am 20. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Unicredit Bank, Ag London Branch
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 26. Juni 2008
    Geliefert am 11. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured italian creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 11. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A security agreement
    Erstellt am 21. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured row creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag, London Branch (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A security agreement
    Erstellt am 19. Aug. 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag London Branch as Security Agent
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0