TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD
Überblick
| Unternehmensname | TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 05450425 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| QUAYSHELFCO 1151 LIMITED | 12. Mai 2005 | 12. Mai 2005 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Davies als Geschäftsführer am 11. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2017 bis 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 11. Aug. 2017 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||||||
Notification of Taylor Continental Group Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrew Ratigan als Sekretär am 01. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Layton Gwyn Tamberlin als Direktor am 01. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Brendan Francis Murphy als Direktor am 01. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Davies als Direktor am 17. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Francis Keegan als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 18 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY, Brendan Francis | Geschäftsführer | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire | United Kingdom | Irish | 126815000002 | |||||
| SANDERS, Richard Barry | Geschäftsführer | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire | England | British | 188989120001 | |||||
| TAMBERLIN, Layton Gwyn | Geschäftsführer | c/o Sullivan Street Partners Seymour Street W1H 7JA London 26 England | United Kingdom | British | 177623140002 | |||||
| COLLINS, Barry David | Sekretär | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire | 183421940001 | |||||||
| LEWIS, Colin John | Sekretär | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire | British | 103938340001 | ||||||
| RATIGAN, Paul Andrew | Sekretär | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire | 187270880001 | |||||||
| NQH (CO SEC) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Narrow Quay House Narrow Quay BS1 4AH Bristol | 900001160001 | |||||||
| ANCELL, James Ross | Geschäftsführer | The Old Rectory Rectory Lane Cromhall GL12 8AN Wotton Under Edge Gloucestershire | United Kingdom | New Zealander | 5839620005 | |||||
| CHAPMAN, Richard | Geschäftsführer | 36 Overstone Road AL5 5PJ Harpenden Hertfordshire | England | British | 105780940002 | |||||
| DAVIES, Andrew | Geschäftsführer | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire | England | Welsh | 167775130002 | |||||
| GILLETT, David Alan, Dr | Geschäftsführer | 12 The Lea DY11 6JY Kidderminster Worcestershire | England | British | 113123610001 | |||||
| KEEGAN, Nicholas Francis | Geschäftsführer | Oak Park, Ryelands Lane Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Worcestershire | England | British | 103638150001 | |||||
| LEWIS, Colin John | Geschäftsführer | 10 St Michaels Road CV35 8NT Claverdon Warwickshire | United Kingdom | British | 103938340001 | |||||
| SELKIRK, Peter Ericson | Geschäftsführer | Dragon Wentwood NP26 3AZ Caldicot Monmouthshire | Uk | British | 48130800006 | |||||
| TAYLOR, Alden Egbert Fenton | Geschäftsführer | The Shortyard DY11 5XF Wolverley Sinkers Cottage Worcestershire Uk | England | British | 105780230003 | |||||
| WARREN, Christopher Laurence | Geschäftsführer | 16 Khyber Road SW11 2PZ London | England | British | 141578530002 | |||||
| WILLIAMS, David John | Geschäftsführer | 30 Ploverdale Crescent DY6 8XT Kingswinford West Midlands | England | British | 93043120001 | |||||
| NQH LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Narrow Quay House Narrow Quay BS1 4AH Bristol | 900001150001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Continental Group Ltd | 06. Apr. 2016 | Elmley Lovett WR9 0QZ Droitwich Oak Park, Ryelands Lane Worcestershire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 13. Juli 2017 | 13. Juli 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat TAYLOR CONTINENTAL FUNDING LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 14. Okt. 2011 Geliefert am 21. Okt. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Juni 2005 Geliefert am 21. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as quayshelfco 1151 limited to the investor security trustee and the investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Juni 2005 Geliefert am 11. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each security provider to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings to the west sideof ryelands farm, hartlebury, hereford and worcester and strip of land adjoining. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0