GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED

GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05452924
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LLOYDS TSB GENERAL LEASING (NO.10) LIMITED16. Mai 200516. Mai 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Richard Owen Williams als Geschäftsführer am 09. Sept. 2016

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Gerard Ashley Fox als Direktor am 09. Sept. 2016

    3 SeitenAP01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:C.O. To remove/replace liquidator
    11 SeitenLIQ MISC OC

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:removing Kerry Trigg
    1 SeitenLIQ MISC

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 Seiten4.71

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 1 More London Place London SE1 2AF verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Gresham Street London EC2V 7HN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 20. Okt. 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beendigung der Bestellung von Colin Graham Dowsett als Geschäftsführer am 16. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 31 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 30 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 32 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 29 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 34 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 26 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 33 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 27 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 28 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Sekretär
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02791894
    73512200003
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    United KingdomBritish216937250001
    SLATTERY, Sharon Noelle
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Bevollmächtigter Sekretär
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    British900029450001
    BASING, Anthony Mark
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    British99221710001
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Geschäftsführer
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    EnglandBritish152332230001
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British900029440001
    FOSTER, Jonathan Scott
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish59795070002
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Geschäftsführer
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish152766650002
    GRANT, Mark Andrew
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    Geschäftsführer
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    United KingdomBritish236442470001
    HERBERT, Jon Mark
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Geschäftsführer
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish203539400001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JOSEPH, Michael William
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish44954410002
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British900029430001
    PELLY, Richard Fowler
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    Geschäftsführer
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    EnglandBritish99868440002
    VOWLES, Anthony Brian
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Hopgardens
    Hopgarden Lane
    TN13 1PX Sevenoaks
    Kent
    British75134410001
    WILLIAMS, Richard Owen
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish164554190001

    Hat GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of general assignment
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and / or the guarantor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The insurances, the lease agreement, the lessee's assignment, and all claims, rights and remedies arising therefrom and the requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of covenants
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    17,300 dwt multi-purpose cargo vessel named "arneborg". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A. (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of general assignment
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of general assignment
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security over shares agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security over shares agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of covenants
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the vessel being 17,300 dwt multi purpose cargo vessel named amstelborg. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.a (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of general assignment
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rights, title and interest in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All respective rights, title and interest in and to the vessel being the 17,300 dwt multi purpose cargo vessel registered in the name of the owner under dutch flag and named amazoneborg and includes any share or interest therein and her appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A. (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security over shares agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The partnership charges its interest in the trust over the shares meaning all allotments accretions benefits and advantages all certificates and all moneys dividends and interest in relation to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A. (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A security over shares agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the time charterer and/or the guarantor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its beneficial interest in the shares being one ordinary share in the share capital of the company all rights related to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A. (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A disclosed pledge of rights under sterling accounts including insurance proceeds
    Erstellt am 13. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A disclosed right of pledge over the rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A disclosed pledge of rights under sterling accounts including insurance proceeds
    Erstellt am 13. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A disclosed right of pledge over the rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A disclosed pledge of rights under sterling accounts including insurance proceeds
    Erstellt am 13. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A disclosed right of pledge over the rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Rabobank Groningen E.O. U.A.
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A disclosed pledge of rights under sterling accounts including insurance proceeds
    Erstellt am 13. Aug. 2007
    Geliefert am 29. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sterling account pledge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperative Rabobank Groningen E.O U.A
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 17. März 2006
    Geliefert am 29. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the security parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged property by way of a first fixed charge. Charged property means all of the rights, title and interest in and to the refund guarantee and the novated shipbuilding contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transaktionen
    • 29. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 17. März 2006
    Geliefert am 29. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the security parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged property by way of a first fixed charge. Charged property means all of the rights, title and interest in and to the refund guarantee and the novated shipbuilding contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transaktionen
    • 29. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 17. März 2006
    Geliefert am 29. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the security parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged property by way of a first fixed charge. Charged property means all of the rights, title and interest in and to the refund guarantee and the novated shipbuilding contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transaktionen
    • 29. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security over shares agreement
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any of the relevant parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge for the payment and discharge of all of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security over shares agreement
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any of the relevant parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge for the payment and discharge of all of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security over shares agreement
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any of the relevant parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge for the payment and discharge of all of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security over shares agreement
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any of the relevant parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the payment and discharge of all of the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of covenants relating to M.V. amstelborg
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any relevant party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All their respective rights title and interest in and to the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of covenants relating to M.V. arneborg
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any relevant party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All their respective rights title and interest in and to the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of covenants relating to M.V. amazoneborg
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 12. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any relevant party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All their respective rights title and interest in and to the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat GENERAL LEASING (NO. 10) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Sept. 2015Beginn der Liquidation
    07. Dez. 2016Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kerry Lynne Trigg
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0