SC WINSFORD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSC WINSFORD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05463768
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SC WINSFORD LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich SC WINSFORD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o CURRIE YOUNG LTD
    Alexander House Waters Edge Business Park
    Campbell Road
    ST4 4DB Stoke On Trent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SC WINSFORD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für SC WINSFORD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    15 SeitenLIQ14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O the Currie Young Ltd the Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane Stoke on Trent Staffordshire ST3 6HP zum C/O Currie Young Ltd Alexander House Waters Edge Business Park Campbell Road Stoke on Trent ST4 4DB am 13. Jan. 2017

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 17 Alvaston Business Park Middlewich Road Nantwich Cheshire CW5 6PF zum C/O the Currie Young Ltd the Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane Stoke on Trent Staffordshire ST3 6HP am 12. Aug. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Juli 2016

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 16. Juni 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 15. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 06. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2013

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Mai 2012 bis 30. Mai 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 01. Juni 2010

    • Kapital: GBP 2
    2 SeitenSH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2008

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SC WINSFORD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHANTLER, Melanie Suzanne
    Stretton Hall Farm Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    Sekretär
    Stretton Hall Farm Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    British51710220001
    CHANTLER, Simon
    Stretton Hall Farm
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Stretton Hall Farm
    Tilston
    SY14 7JA Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish95498410001

    Hat SC WINSFORD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 11. Okt. 2007
    Geliefert am 18. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Okt. 2007
    Geliefert am 18. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at hooton farm hooton south wirral. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2006
    Geliefert am 05. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings on the south east, north west and south west side of road five winsford industrial estate winsford t/n CH119326 and CH214188. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 05. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2006
    Geliefert am 05. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 05. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Okt. 2005
    Geliefert am 20. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SC WINSFORD LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Juli 2016Beginn der Liquidation
    12. Dez. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Praktiker
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Praktiker
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0