2005 PROPCO THREE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname2005 PROPCO THREE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05465822
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 2005 PROPCO THREE LIMITED?

    • Glücksspiel- und Wettbetriebe (92000) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich 2005 PROPCO THREE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 2005 PROPCO THREE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GALA PROPCO THREE LIMITED15. Aug. 200515. Aug. 2005
    CYCLEBRIDGE LIMITED27. Mai 200527. Mai 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 2005 PROPCO THREE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für 2005 PROPCO THREE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für 2005 PROPCO THREE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 Seiten4.72

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Geänderte Geschäftsanschrift vom New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT zum Suite a, 7Th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS am 19. März 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 03. März 2015

    LRESEX

    **Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 13

    5 SeitenMR05

    **Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 13

    5 SeitenMR05

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2014 bis 03. März 2015

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Carl Anthony Leaver als Geschäftsführer am 24. Feb. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert William Templeman als Geschäftsführer am 23. Feb. 2015

    1 SeitenTM01

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 13

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 31

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 32

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 18

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 17

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 29

    5 SeitenMR05

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 29

    6 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 26

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 22

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 27

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 25

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 24

    5 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 23

    5 SeitenMR05

    Wer sind die Geschäftsführer von 2005 PROPCO THREE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Sekretär
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    BOWTELL, Paul
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A, 7th Floor
    Geschäftsführer
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A, 7th Floor
    United KingdomBritish164343080001
    TEMPLEMAN, Robert William
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    EnglandBritish159382420001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    BROADHEAD, John David
    311 Naylor Building West
    1 Assam Street
    E1 7QL London
    Sekretär
    311 Naylor Building West
    1 Assam Street
    E1 7QL London
    British104665790001
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROADHEAD, John David
    311 Naylor Building West
    1 Assam Street
    E1 7QL London
    Geschäftsführer
    311 Naylor Building West
    1 Assam Street
    E1 7QL London
    British104665790001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    EnglandBritish151637880001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    HARRISON, Dominic Stephen
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    United KingdomBritish107909600001
    HUGHES, Gary William
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    ScotlandBritish151269910001
    KELLY, John Michael
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish141916500001
    LEAVER, Carl Anthony
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish159381090001
    POWER, Shona
    48 Macaulay Square
    SW4 0RS London
    Geschäftsführer
    48 Macaulay Square
    SW4 0RS London
    British105746250001
    PROCTOR, Matthew Frederick
    49 Moira Road
    LE65 2GB Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    49 Moira Road
    LE65 2GB Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British69927790002
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    British100607290001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    TEMPLEMAN, Robert William
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish159382420002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat 2005 PROPCO THREE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 20. Dez. 2013
    Geliefert am 24. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag. London Branch
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 07. Nov. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Nov. 2013
    Geliefert am 22. Nov. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    528 sauchiehall street glasgow and 359 renfrew street t/no GLA106258. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 07. Nov. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 2008
    Geliefert am 29. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land at the rear of the gala bingo club beaumont way beaumont leys leicester.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 2007
    Geliefert am 13. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at basingstoke leisure park basingstoke t/no HP523042, gala bingo club waterside centre saltergate lincoln t/no LL110910, gala club on south side of marine road east morecambe t/no LL677132, the gala casino on the west side 9 chaloner street liverpool casino t/no MS399287.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 13. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10 july 2007 and
    Erstellt am 05. Juli 2007
    Geliefert am 26. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The lease of the bingo premises at faraday retail park coatbank street coatbridge t/n LAN97079.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 26. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Assignation of rental income
    Erstellt am 05. Juli 2007
    Geliefert am 23. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargors whole right title and interest in and to the rent and all other monies in terms of the leases of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Assignation of rental income dated 1ST march 2007 and
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 20. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right, title and interest in and to the rent. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 20. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2014Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 22. Jan. 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 28. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 06. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The mortgaged property being gala social club, high street, acton, london t/no AGL114684; 377 lichfield road, ashmore park, wolverhampton t/no WM180505; land on the east side of oldham, ashton-under-lyne t/no GM709477, for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 06. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 105. Nov. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 127. Nov. 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 06. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery, for details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 06. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 12. März 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 12. März 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenant's interest in the lease of the premises comprising the riverboat casino, broomielaw, glasgow t/no GLA115876.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the premises at flemington road, glenthoes t/no ffe 38781.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the premises at crosshill street and orbiston street, motherwell t/nos lan 65279 and lan 105015.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the bingo club premises at 41/43 townhead, irvine t/no AYR17535.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole 1, 2 and 3 kerse lane, falkirk t/no STG6346.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the premises 28 north carbrain road cumbernauld t/no dmb 39270.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects comprising a bingo club and adjacent land being subjects on the north side of hawthorn street, glasgow t/no GLA25035.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the casino premises at 528 sauchiehall street, glasgow t/no gla 106258.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2007 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the casino premises and others comprising the ground floor premises at 61/63 (formerly 55/57) summer street, aberdeen and lane pertaining thereto.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 5TH march 2007 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects comprising the kingsway bingo club situated on the basement, ground and first and second floors of the building k/a and forming one hundreds and two/one hundred and sixteen king street aberdeen in the city, parish and county of aberdeen.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the tenants interest in the lease of subjects on the south east side of craigmont drive, glasgow t/no GLA100633.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 5TH march 2007 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a 59, 61, and 63 marischall street, peterhead t/no abn 05561.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a 154 west granton road, edinburgh t/no mid 101539.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH march 2006 and
    Erstellt am 01. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a edinburgh maybury casino, 5 south maybury road, edinburgh t/no mid 81287.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2014Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Assignation of rents
    Erstellt am 23. Dez. 2005
    Geliefert am 10. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The right title interest and benefit in and to the rental income and all rental deposits and guarantees held pursuant or supplemental to the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Security Agent and Trustee for the Benefit of the Financeparties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The supplemental mortgage deed
    Erstellt am 22. Dez. 2005
    Geliefert am 23. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatosever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the gala social club centenary way t/n LA905512. The f/h property k/a the gala social club centenary way t/n LA53177. The l/h property k/a land and buildings to the west of holwell road suffon fields t/n HS229493. For further details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat 2005 PROPCO THREE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Deborah Janet King
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Receiver Manager
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Receiver Manager
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    03. März 2015Beginn der Liquidation
    28. Okt. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praktiker
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Jill Sandford
    7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0