REDBOARD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREDBOARD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05467915
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REDBOARD LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich REDBOARD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von REDBOARD LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MODUS STOURBRIDGE LIMITED08. Feb. 200608. Feb. 2006
    COLERIDGE (NO.42) LIMITED01. Juni 200501. Juni 2005

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REDBOARD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für REDBOARD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Apr. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    16 SeitenAA

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Okt. 2008

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    1 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    legacy

    1 Seiten287

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed modus stourbridge LIMITED\certificate issued on 30/07/08
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2006

    16 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    16 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten403a

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von REDBOARD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, John Elwyn
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    British84729210001
    DAVIES, John Elwyn
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    2 Hollowgate
    Swinton
    M27 0AD Manchester
    Lancashire
    BritishAccountant84729210001
    LOCKHART, David
    20 Alder Drive
    Timperley
    WA15 7YG Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 Alder Drive
    Timperley
    WA15 7YG Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director106873770001
    MACFARLANE, Oliver Peter Patrick
    7 Chichester Close
    Sale
    M33 4TR Manchester
    Geschäftsführer
    7 Chichester Close
    Sale
    M33 4TR Manchester
    United KingdomBritishCompany Director103382840001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Sekretär
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    98515470001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Sekretär
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    DWS DIRECTORS LTD
    Five Chancery Lane
    Clifford's Inn
    EC4A 1BU London
    Geschäftsführer
    Five Chancery Lane
    Clifford's Inn
    EC4A 1BU London
    111005580001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Hat REDBOARD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2006
    Geliefert am 13. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as coleridge (no.42) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H the crown centre stourbridge t/no WM319506. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2006
    Geliefert am 13. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as coleridge (no.42) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 01. Feb. 2006
    Geliefert am 03. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or modus alpha property partners LP to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in all rents in relation to the l/h property known as the crown centre stourbridge t/n WM319506,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2006
    Geliefert am 03. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as the crown centre stourbridge t/n WM319506,. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2006
    Geliefert am 03. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Juli 2005
    Geliefert am 21. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as the crown centre stourbridge t/n WM319506,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juli 2005
    Geliefert am 21. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat REDBOARD LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Okt. 2008Beginn der Liquidation
    20. Aug. 2010Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Granville Firmin
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0