PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED

PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05472584
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Planehouse Ltd Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    Gwynedd
    Wales
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Planehouse Limited Llandygai Industrial Estate Llandygai Bangor Gwynedd LL57 4YH zum C/O Planehouse Ltd Unit 6 Llys Castan Parc Menai Business Park Bangor Gwynedd LL57 4FH am 21. Dez. 2018

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Watkin Jones am 22. Juni 2017

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    18 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    14 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 08. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 24. Juni 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    15 SeitenAA

    Ernennung von Mr Julian Nigel Tregoning Browne als Sekretär am 03. Juni 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Watkin Jones als Sekretär am 03. Juni 2014

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Juni 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Watkin Jones am 03. Juni 2014

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    15 SeitenAA

    Ernennung von Mr Julian Nigel Tregoning Browne als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    17 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Rebecca Hopewell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWNE, Julian Nigel Tregoning
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    Sekretär
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    British179133870001
    BROWNE, Julian Nigel Tregoning
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    WalesBritish179133870001
    WATKIN JONES, Glyn
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    WalesWelsh77892600001
    WATKIN JONES, Jennifer Anne
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    WalesBritish45447290001
    WATKIN JONES, Mark
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    Unit 6 Llys Castan
    Parc Menai Business Park
    LL57 4FH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    WalesBritish73218710007
    DAVIDSON, George Charles Smith
    44 Clwyd Park
    Kinmel Bay
    LL18 5EJ Rhyl
    Clwyd
    Sekretär
    44 Clwyd Park
    Kinmel Bay
    LL18 5EJ Rhyl
    Clwyd
    British62175860001
    DEXTER, Graeme Peter Andrew
    72 Gorwel
    LL33 0DT Llanfairfechan
    Gwynedd
    Sekretär
    72 Gorwel
    LL33 0DT Llanfairfechan
    Gwynedd
    British76695610001
    HINDMARCH, Andrew John
    45 Bryntirion Drive
    LL19 9NT Prestatyn
    Briarwood
    Denbighshire
    Sekretär
    45 Bryntirion Drive
    LL19 9NT Prestatyn
    Briarwood
    Denbighshire
    British150489110001
    WATKIN JONES, Mark
    c/o Planehouse Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    Sekretär
    c/o Planehouse Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    British73218710004
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    DAVIDSON, George Charles Smith
    44 Clwyd Park
    Kinmel Bay
    LL18 5EJ Rhyl
    Clwyd
    Geschäftsführer
    44 Clwyd Park
    Kinmel Bay
    LL18 5EJ Rhyl
    Clwyd
    WalesBritish62175860001
    HINDMARCH, Andrew John
    45 Bryntirion Drive
    LL19 9NT Prestatyn
    Briarwood
    Denbighshire
    Geschäftsführer
    45 Bryntirion Drive
    LL19 9NT Prestatyn
    Briarwood
    Denbighshire
    United KingdomBritish78311850001
    HOPEWELL, Rebecca
    c/o Planehouse Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    Geschäftsführer
    c/o Planehouse Limited
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    Llandygai Industrial Estate
    Gwynedd
    Wales
    EnglandBritish120263630001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Planehouse Ltd
    Llandygai Industrial Estate
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    06. Apr. 2016
    Llandygai Industrial Estate
    Llandygai
    LL57 4YH Bangor
    C/O Planehouse Ltd
    Gwynedd
    Wales
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandWales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUk Companies Registry
    Registrierungsnummer04899241
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat PLANEHOUSE RESIDENTIAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Third party legal charge
    Erstellt am 02. Juni 2009
    Geliefert am 10. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,750,000 due or to become due from carlton north wales limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a 7 somerhill park, wrexham t/no. CYM264543, 10 somerhill park, wrexham t/no. CYM264554, 12 somerhill park, wrexham t/no. CYM264544, 15 somerhill park, wrexham t/no. CYM264545,.
    Berechtigte Personen
    • The Trustees of the Glyn Watkin Jones 1999 Hybrid Settlement
    Transaktionen
    • 10. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 19. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ploy 28 llys tregarnedd llangefni. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 19. Mai 2006
    Geliefert am 31. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 24. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 28 st josephs llangefni anglesey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Feb. 2006
    Geliefert am 21. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H deganwy chapel deganwy avenue deganwy. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 1 the oaks trevor. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being plot 15 the park summerhill wrexham, goodwill, and any rental payable under any lease,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being plot 7 the park summerhill wrexham, goodwill, and any rental payable under any lease,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being plot 12 the park summerhill wrexham, goodwill, and any rental payable under any lease,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being plot 10 the park summerhill wrexham, goodwill, and any rental payable under any lease,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9 apartments at and above the post office llandudno. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Aug. 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - 4 houses at church road, rhos on sea. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 2005
    Geliefert am 20. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2005
    Geliefert am 06. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - 9 houses at tan y llan ruabon. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0